Actos BORME de Stejasa Agregados Industriales Sa
27 de Mayo de 2020Otros conceptos: CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA SU HOJA REGISTRAL. Extinción. Datosregistrales. T 34325 , F 91, S 8, H M 77560, I/A 51 (20.05.20).
03 de Abril de 2020Otros conceptos: Cierre provisional de la hoja social por plazo de seis meses de conformidad con lo preceptuado en el artículo 231RRM. Datos registrales. T 34325 , F 91, S 8, H M 77560, I/A 50M (27.03.20).
29 de Marzo de 2017Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Revocaciones. Apo.Sol.: VICTORIO GONZALEZ JUANMANUEL. Apo.Manc.: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE;LIGONIE MIJANCOS FRANCK-ALAIN;SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO.Apo.Sol.: GALINDO ALONSO ARTURO. Apo.Manc.: ARTIGAS REYNAUD JEAN MICHEL. Apo.Sol.: MARTINEZ TELLECHEA IVAN.Apo.Manc.: ROBLEDO CABEZUELA RAUL. Nombramientos. SecreNoConsj: MOLINA SANZ LEANDRO. Apoderado: VICTORIOGONZALEZ JUAN MANUEL;MOLINA SANZ LEANDRO;LIGONIE MIJANCOS FRANCK;SANCHEZ ILLERA JOSEANTONIO;GALINDO ALONSO ARTURO;ARTIGAS REYNAUD JEAN MICHEL;MARTINEZ TELLECHEA IVAN;ROBLEDOCABEZUELA RAUL. Datos registrales. T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 49 (21.03.17).
Modificaciones estatutarias. Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3. Datos registrales. T 34325 , F 90, S 8, H M 77560, I/A 50(21.03.17).
25 de Enero de 2017Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 34325 , F 89, S 8, H M 77560, I/A 48 (18.01.17).
22 de Septiembre de 2016Declaración de unipersonalidad. Socio único: AAF SA. Datos registrales. T 34325 , F 88, S 8, H M 77560, I/A 47 (15.09.16).
18 de Marzo de 2016Revocaciones. Apoderado: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE;SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO;LIGONIE MIJANCOS FRANCKALAIN;GALINDO ALONSO ARTURO. Nombramientos. Apo.Manc.: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL. Apo.Sol.: VICTORIOGONZALEZ JUAN MANUEL;GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Apo.Manc.: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE;LIGONIE MIJANCOSFRANCK-ALAIN;SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO;GALINDO ALONSO ARTURO. Apo.Sol.: GALINDO ALONSO ARTURO.Apo.Manc.: ARTIGAS REYNAUD JEAN MICHEL;MARTINEZ TELLECHEA IVAN. Apo.Sol.: MARTINEZ TELLECHEA IVAN;ROBLEDOCABEZUELA RAUL. Apo.Manc.: ROBLEDO CABEZUELA RAUL. Datos registrales. T 4723 , F 225, S 8, H M 77560, I/A 46(10.03.16).
17 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO. Con.Delegado: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL.Presidente: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL;GARCIA ESPARZA LUISFELIPE. Secretario: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Consejero: LIGONIE MIJANCOS FRANCK ALAIN. Nombramientos.SecreNoConsj: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Consejero: ALLSOPP DARREN;ARREGUI DIAZ DE HEREDIA ALBERTO;PURVISANDY. Presidente: ALLSOPP DARREN. Datos registrales. T 4723 , F 224, S 8, H M 77560, I/A 45 ( 9.03.16).
18 de Enero de 2016Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 224, S 8, H M 77560, I/A 44 (11.01.16).
14 de Enero de 2015Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 224, S 8, H M 77560, I/A 43 ( 5.01.15).
22 de Enero de 2014Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 223, S 8, H M 77560, I/A 42 (14.01.14).
31 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 223, S 8, H M 77560, I/A 41 (21.12.12).
10 de Abril de 2012Nombramientos. Consejero: SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO. Reelecciones. Con.Delegado: VICTORIO GONZALEZ JUANMANUEL. Presidente: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL;GARCIAESPARZA LUIS FELIPE. Secretario: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Consejero: LIGONIE MIJANCOS FRANCK ALAIN.Modificaciones estatutarias. MODIFICACION ARTICULO 21º.- . Datos registrales. T 4723 , F 223, S 8, H M 77560, I/A 40(28.03.12).
14 de Noviembre de 2011Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 222, S 8, H M 77560, I/A 39 (28.10.11).
22 de Marzo de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE;LIGONIE MIJANCOS FRANCK ALAIN;SANCHEZ ILLERA JOSEANTONIO;GALINDO ALONSO ARTURO. Datos registrales. T 4723 , F 221, S 8, H M 77560, I/A 35 ( 9.03.11).
Nombramientos. Apoderado: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE;SANCHEZ ILLERA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4723 , F221, S 8, H M 77560, I/A 36 ( 9.03.11).
Nombramientos. Apoderado: LIGONIE MIJANCOS FRANCK ALAIN. Datos registrales. T 4723 , F 221, S 8, H M 77560, I/A 37 (9.03.11).
Nombramientos. Apoderado: GALINDO ALONSO ARTURO. Datos registrales. T 4723 , F 222, S 8, H M 77560, I/A 38 ( 9.03.11).
17 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 221, S 8, H M 77560, I/A 34 ( 4.01.11).
18 de Diciembre de 2009Reelecciones. Auditor: GAMEZ ROMAN ANTONIO FRANCISCO. Aud.Supl.: GONZALEZ GARCIA MARIA DE LA ALMUDENA.Datos registrales. T 4723 , F 220, S 8, H M 77560, I/A 33 ( 9.12.09).
04 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: CARCELLER LEON MANUEL. Consejero: CARCELLER LEON MANUEL;PINO PALMA BEATRIZ.Nombramientos. Consejero: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Secretario: GARCIA ESPARZA LUIS FELIPE. Consejero: LIGONIEMIJANCOS FRANCK ALAIN. Reelecciones. Con.Delegado: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL. Presidente: VICTORIOGONZALEZ JUAN MANUEL. Consejero: VICTORIO GONZALEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 4723 , F 220, S 8, H M 77560,I/A 32 (23.01.09).