Actos BORME de Step One Ventures Sl
26 de Junio de 2023Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 9 - PLANTA 0, EDIFICIO ATOCHA CEN (MADRID). Datos registrales. T 25619, F 225, S 8, H M 461635, I/A 22 (19.06.23).
31 de Marzo de 2022Ceses/Dimisiones. Representan: MARTIN BERNARDOS LUIS-ANTONIO. Adm. Solid.: LLITARRADA INNOVA SL. Datosregistrales. T 25619 , F 225, S 8, H M 461635, I/A 21 (24.03.22).
26 de Marzo de 2020Declaración de unipersonalidad. Socio único: LLITARRADA INNOVA SL. Datos registrales. T 25619 , F 225, S 8, H M 461635,I/A 20 (19.03.20).
09 de Octubre de 2017Cambio de domicilio social. C/ MENDEZ ALVARO 9 - 3ª PLANTA, EDIFICIO ATOCHA CE (MADRID). Datos registrales. T 25619 ,F 225, S 8, H M 461635, I/A 19 (29.09.17).
21 de Diciembre de 2015Revocaciones. Apoderado: ORIA ALMUDI MARIA. Datos registrales. T 25619 , F 225, S 8, H M 461635, I/A 18 (14.12.15).
23 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO;BARRABES CONSUL JUAN CARLOS. Nombramientos.Representan: BARRABES CONSUL JUAN CARLOS;MARTIN BERNARDOS LUIS-ANTONIO. Adm. Solid.: BARRABES INTERNETSL;LLITARRADA INNOVA SL. Datos registrales. T 25619 , F 224, S 8, H M 461635, I/A 17 (14.07.15).
13 de Junio de 2012Cambio de domicilio social. C/ SERRANO 16 - PRIMERO, TERCERA (MADRID). Datos registrales. T 25619 , F 94, S 8, H M461635, I/A 15 ( 1.06.12).
Revocaciones. Apoderado: PARTEARROYO MARTIN JOSE ANGEL;FANJUL SUAREZ MARIA;FANJUL SUAREZ MARIA;FANJULSUAREZ MARIA;MORENO CASAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 25619 , F 224, S 8, H M 461635, I/A 16 ( 1.06.12).
01 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO. Nombramientos. Adm. Solid.: HERNANDEZ GONZALEZBERNARDO;BARRABES CONSUL JUAN CARLOS. Datos registrales. T 25619 , F 93, S 8, H M 461635, I/A 13 (21.02.12).
Nombramientos. Apoderado: ORIA ALMUDI MARIA. Datos registrales. T 25619 , F 94, S 8, H M 461635, I/A 14 (21.02.12).
29 de Septiembre de 2011Nombramientos. Apoderado: MORENO CASAS JOSE LUIS. Datos registrales. T 25619 , F 93, S 8, H M 461635, I/A 12 (19.09.11).
19 de Enero de 2011Nombramientos. Apoderado: FANJUL SUAREZ MARIA. Datos registrales. T 25619 , F 93, S 8, H M 461635, I/A 11 (10.01.11).
03 de Enero de 2011Cambio de domicilio social. C/ ALMIRANTE 30 5º - DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 25619 , F 93, S 8, H M 461635, I/A10 (21.12.10).
03 de Mayo de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO;AQUINO JENNIFER ANN. Nombramientos. Adm. Unico:HERNANDEZ GONZALEZ BERNARDO. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Administradoressolidarios a Administrador único. Datos registrales. T 25619 , F 92, S 8, H M 461635, I/A 8 (22.04.10).
Revocaciones. Apoderado: AQUINO JENNIFER ANN. Nombramientos. Apoderado: FANJUL SUAREZ MARIA. Datos registrales.T 25619 , F 92, S 8, H M 461635, I/A 9 (22.04.10).
19 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOPERENA DE SAA GERMAN RAMON. Nombramientos. Adm. Solid.: AQUINO JENNIFER ANN.Datos registrales. T 25619 , F 91, S 8, H M 461635, I/A 7 ( 6.10.09).
05 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: AQUINO JENNIFER ANN. Datos registrales. T 25619 , F 89, S 8, H M 461635, I/A 5 (24.07.09).
Nombramientos. Apoderado: FANJUL SUAREZ MARIA. Datos registrales. T 25619 , F 90, S 8, H M 461635, I/A 6 (24.07.09).