Buscador CIF Logo

Actos BORME Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima

Actos BORME Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima - A87654323

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima con CIF A87654323

馃敊 Perfil de Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Student Properties Spain Socimi Sociedad Anonima

20 de Noviembre de 2023
Transformaci贸n de sociedad. Denominaci贸n y forma adoptada: STUDENT PROPERTIES SPAIN SL. Ceses/Dimisiones.Ent.Reg.Cont: SOCIEDAD DE GESTION DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO CO. Consejero: SNAUWAERT FREDERIK EVARISTEA.;TEUNISSEN CHRISTIAN GUSTAAF;GRIJPINK BASTIAAN PIETER JOHAN. Presidente: TEUNISSEN CHRISTIAN GUSTAAF.SecreNoConsj: CONDE VI脩UELAS VICENTE. VsecrNoConsj: BLANCO GONZALEZ RAQUEL. Revocaciones. Apoderado:

08 de Marzo de 2023
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 44451 , F 184, S 8, H M 633177,I/A 29 ( 1.03.23).

10 de Febrero de 2023
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: XIOR STUDENT HOUSING NV. Datos registrales. T 44451 , F 183, S 8, H M633177, I/A 28 ( 3.02.23).

20 de Enero de 2023
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: HUBR SEVILLA SOCIMI SA. HUBR MALAGA SOCIMI SA. Datos registrales. T35553 , F 57, S 8, H M 633177, I/A 27 (13.01.23).

14 de Diciembre de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 11.059,80 Euros. Resultante Suscrito: 22.714.424,69 Euros. Datos registrales. T 35553 ,F 56, S 8, H M 633177, I/A 26 ( 5.12.22).

04 de Octubre de 2022
Reelecciones. Consejero: SNAUWAERT FREDERIK EVARISTE A.;TEUNISSEN CHRISTIAN GUSTAAF;GRIJPINK BASTIAANPIETER JOHAN. Presidente: TEUNISSEN CHRISTIAN GUSTAAF. Modificaciones estatutarias. Modificados los art铆culos 14, 23, 33y 35 de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 35553 , F 54, S 8, H M 633177, I/A 25 (27.09.22).

22 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: SNAUWAERT FREDERIK EVARISTE A.;BAL VERONIQUE JOZEF A.;ROBBERECHTS SOFIE DENISEAApo.Manc.: RIVERO CALDERON LUCIA;CAMPOS MADRAZO MARIA ROSA;AGUADO GARCIA VANESSA. Datos registrales. T35553 , F 51, S 8, H M 633177, I/A 24 (15.03.22).

29 de Septiembre de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CORRAL POZUELO LUIS MIGUEL;VALDES FERNANDEZ PABLO. MiemComAuCnt: CORRALPOZUELO LUIS MIGUEL. PresComAuCnt: CORRAL POZUELO LUIS MIGUEL. Consejero: ROCA ORTEGA FRANCISCO;ZURITAGO脩I MIGUEL. MiemComAuCnt: ZURITA GO脩I MIGUEL;ROCA ORTEGA FRANCISCO. Consejero: WILLEM HERO GYSBREGHT.Presidente: WILLEM HERO GYSBREGHT. SecreNoConsj: ARTEAGABEITIA GONZALEZ IDOYA. VsecrNoConsj: CASTELLOBERNABEU INMACULADA. Nombramientos. Consejero: SNAUWAERT FREDERIK EVARISTE A.;TEUNISSEN CHRISTIANGUSTAAF;GRIJPINK BASTIAAN PIETER JOHAN. SecreNoConsj: CONDE VI脩UELAS VICENTE. VsecrNoConsj: BLANCOGONZALEZ RAQUEL. Presidente: TEUNISSEN CHRISTIAN GUSTAAF. Datos registrales. T 35553 , F 46, S 8, H M 633177, I/A 21(22.09.21).

Revocaciones. Apo.Manc.: WILLEM HERO GYSBREGHT;CORRAL POZUELO LUIS MIGUEL;ROCA ORTEGAFRANCISCO;ZURITA GO脩I MIGUEL;VALDES FERNANDEZ PABLO. Nombramientos. Apoderado: GRIJPINK BASTIAAN PIETERJOHAN. Datos registrales. T 35553 , F 47, S 8, H M 633177, I/A 22 (22.09.21).

Nombramientos. Apo.Sol.: MATOS MARTINEZ JULIAN;MIRANDA RIERA DAVID;CALSAMIGLIA MENDLEWICZOSCAR;CASACUBERTA BAUSILI CARLOS;BARONA CONESA SARA;DE LA CRUZ GALAN LAURA;BRUGUER MERELLOIGNASI;LAO MARZO MARTA;NAVA GARRIDO DAVID;MONTEHERMOSO LLUBERA MARIA;MUR ROCAFORT ANA;GARCIA VIVESSANTIAGO;DIAZ ARGELICH PILAR;CONDE VI脩UELAS VICENTE;MENGOTTI MAROTO ALVARO;BLANCO GONZALEZRAQUEL;SAENZ DOMINGUEZ ISABEL. Datos registrales. T 35553 , F 50, S 8, H M 633177, I/A 23 (22.09.21).

20 de Julio de 2021
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 5.890.542,70 Euros. Desembolsado: 5.890.542,70 Euros. Resultante Suscrito: 15.889.549,97 Euros.Resultante Desembolsado: 15.889.549,97 Euros. Datos registrales. T 35553 , F 39, S 8, H M 633177, I/A 19 (13.07.21).

Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 6.835.934,52 Euros. Desembolsado: 6.835.934,52 Euros. Resultante Suscrito: 22.725.484,49 Euros.Resultante Desembolsado: 22.725.484,49 Euros. Datos registrales. T 35553 , F 43, S 8, H M 633177, I/A 20 (13.07.21).

21 de Abril de 2021
Reelecciones. SecreNoConsj: ARTEAGABEITIA GONZALEZ IDOYA. Datos registrales. T 35553 , F 38, S 8, H M 633177, I/A 18(14.04.21).

09 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTONSLP. Datos registrales. T 35553 , F 38, S 8, H M 633177, I/A 17 ( 2.03.21).

20 de Abril de 2020
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.001.000,73 Euros. Resultante Suscrito: 9.999.007,27 Euros. Datos registrales. T 35553, F 37, S 8, H M 633177, I/A 16 (13.04.20).

10 de Mayo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: WILLEM HERO GYSBREGHT;CORRAL POZUELO LUIS MIGUEL;ROCA ORTEGA FRANCISCO;DELRIO GAGO PABLO;AGRIMI FABRIZIO. Nombramientos. Apo.Manc.: WILLEM HERO GYSBREGHT;CORRAL POZUELO LUISMIGUEL;ROCA ORTEGA FRANCISCO;ZURITA GO脩I MIGUEL;VALDES FERNANDEZ PABLO. MiemComAuCnt: CORRALPOZUELO LUIS MIGUEL;ZURITA GO脩I MIGUEL;ROCA ORTEGA FRANCISCO. PresComAuCnt: CORRAL POZUELO LUISMIGUEL. Datos registrales. T 35553 , F 36, S 8, H M 633177, I/A 15 (30.04.19).

20 de Julio de 2018
Nombramientos. Consejero: VALDES FERNANDEZ PABLO. Datos registrales. T 35553 , F 36, S 8, H M 633177, I/A 14 (12.07.18).

24 de Mayo de 2018
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL RIO GAGO PABLO. SecreNoConsj: SAAVEDRA MELENDEZ FAUSTINIANO. Nombramientos.SecreNoConsj: ARTEAGABEITIA GONZALEZ IDOYA. VsecrNoConsj: CASTELLO BERNABEU INMACULADA. Datos registrales. T35553 , F 35, S 8, H M 633177, I/A 13 (11.05.18).

20 de Abril de 2018
Modificaciones estatutarias. 3.- Domicilio social y p谩gina web.. 45.- Reglas para la distribuci贸n de dividendos. 51.- Exclusi贸ndenegociaci贸n en el MAB. P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.spssocimi.com. Datosregistrales. T 35553 , F 34, S 8, H M 633177, I/A 12 (13.04.18).

14 de Noviembre de 2017
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 35553 , F 34, S 8, H M 633177,I/A 11 ( 6.11.17).

10 de Noviembre de 2017
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 200.008,00 Euros. Desembolsado: 200.008,00 Euros. Resultante Suscrito: 11.000.008,00 Euros.Resultante Desembolsado: 11.000.008,00 Euros. Datos registrales. T 35553 , F 33, S 8, H M 633177, I/A 10 (31.10.17).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n