Actos BORME de Subus Grupo De Transporte Sl
05 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: SOLER SEMPERE JOSE. Apo.Sol.: SOLER SEMPERE JOSE. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO.Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO. Apo.Manc.: GARCIA PEREZ MARIA. Apo.Sol.: GARCIA PEREZ MARIA. Nombramientos.Apo.Sol.: MARTI CHOLBI JUAN ANTONIO;CANTERO HERNANDEZ RAUL;BOTELLA PAVIA ROBERTO;MOLINA JIMENEZGABRIEL;AGUDO SANCHEZ ANTONIO;FERRANDIZ PEREZ SERGIO;FILLOL ORTEGA ALEJANDRO;BARCELO BONETELENA;ALIAGA GUILLEN ANGEL FRANCISCO. Apo.Manc.: MARTI CHOLBI JUAN ANTONIO;CANTERO HERNANDEZRAUL;BOTELLA PAVIA ROBERTO;MOLINA JIMENEZ GABRIEL;AGUDO SANCHEZ ANTONIO;FERRANDIZ PEREZSERGIO;FILLOL ORTEGA ALEJANDRO;BARCELO BONET ELENA;ALIAGA GUILLEN ANGEL FRANCISCO. Apoderado: RIPOLL DELA VEGA JOSE LUIS. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 30 (28.03.23).
06 de Julio de 2022Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A29 (28.06.22).
20 de Septiembre de 2021Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 28 (10.09.21).
21 de Septiembre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 27 (11.09.20).
19 de Junio de 2019Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 26 (11.06.19).
31 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: CEBRIAN PUERTAS ALEJANDRO. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 25(20.12.18).
04 de Junio de 2018Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 99, S 8, H A 112872, I/A 24 (25.05.18).
05 de Abril de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: ARIAS LOPEZ JOAQUIN SECUNDINO;ARIAS PAREDES ANTONIO;PAREDES MACIA JULIAMARIA;ARIAS PAREDES MARIA JESUS. Presidente: ARIAS LOPEZ JOAQUIN SECUNDINO. Cons.Del.Sol: ARIAS PAREDESANTONIO. Consejero: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS;FRISOMPA VIANA SL. SecreNoConsj: PACHECO CASTELLANOS JUANANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: CORPORACION EMPRESARIAL VECTALIA SA. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 3540 , F 98, S 8, H A 112872, I/A 23(26.03.18).
18 de Mayo de 2017Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 98, S 8, H A 112872, I/A 22 ( 3.05.17).
13 de Enero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: SOMOZA PEREZ ENRIQUE. VsecrNoConsj: GONZALEZ MARTIN SANTIAGO. Nombramientos.Consejero: FRISOMPA VIANA SL. Datos registrales. T 3540 , F 98, S 8, H A 112872, I/A 21 ( 4.01.17).
19 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ARIAS PAREDES ANTONIO;ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS;CANTERO HERNANDEZ RAUL. Apo.Manc.:CANTERO HERNANDEZ RAUL. Apo.Sol.: GREGORIO MONTESINOS LEONARDO. Apo.Manc.: GREGORIO MONTESINOSLEONARDO. Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZBUENO ALBERTO;CANTERO HERNANDEZ RAUL;MATEOS VICENTE CESAREO;SOLER SEMPERE JOSE;GARCIA PEREZMARIA. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO;CANTERO HERNANDEZ RAUL;MATEOS VICENTE CESAREO;SOLER SEMPEREJOSE;GARCIA PEREZ MARIA. Datos registrales. T 3540 , F 97, S 8, H A 112872, I/A 20 (10.10.16).
15 de Junio de 2016Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 97, S 8, H A 112872, I/A 19 ( 7.06.16).
07 de Octubre de 2015Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 97, S 8, H A 112872, I/A 18 (28.09.15).
02 de Diciembre de 2014Nombramientos. Apoderado: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS. Datos registrales. T 3540 , F 97, S 8, H A 112872, I/A 17 (25.11.14).
04 de Septiembre de 2014Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: AUTOBUSES PLAYA DE SAN JUAN SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: TINSERCARTERA SL;G.I. CARTERA SA. Vicepresid.: TINSER CARTERA SL. Datos registrales. T 3540 , F 96, S 8, H A 112872, I/A 16(27.08.14).
20 de Mayo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BURGALETA HERNANDO TOMAS. SecreNoConsj: GONZALEZ MARTIN SANTIAGO.Nombramientos. Consejero: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS. SecreNoConsj: PACHECO CASTELLANOS JUAN ANTONIO.VsecrNoConsj: GONZALEZ MARTIN SANTIAGO. Datos registrales. T 3540 , F 96, S 8, H A 112872, I/A 15 ( 8.05.14).
10 de Abril de 2012Nombramientos. Consejero: G.I. CARTERA SA. Datos registrales. T 3540 , F 96, S 8, H A 112872, I/A 12 (27.03.12).
20 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3540 , F 96, S 8, H A 112872, I/A 11 ( 8.03.12).
27 de Julio de 2011Nombramientos. Cons.Del.Sol: ARIAS PAREDES ANTONIO. Apo.D.Gral.: ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS. Datos registrales. T3312 , F 211, S 8, H A 112872, I/A 9 (15.07.11).
11 de Marzo de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: ARIAS PAREDES ANTONIO;ROMILLO FIDALGO JOSE LUIS;CANTERO HERNANDEZ RAUL.Apo.Manc.: CANTERO HERNANDEZ RAUL. Apo.Sol.: GREGORIO MONTESINOS LEONARDO. Apo.Manc.: GREGORIOMONTESINOS LEONARDO. Apo.Sol.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN. Apo.Manc.: LOPEZ BUENO ALBERTO AGUSTIN.Datos registrales. T 3312 , F 143, S 8, H A 112872, I/A 8 ( 1.03.11).
08 de Febrero de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.633.610,00 Euros. Resultante Suscrito: 29.408.300,00 Euros. Datos registrales. T 3312 , F 143, S8, H A 112872, I/A 7 (27.01.11).
06 de Mayo de 2010Revocaciones. Apoderado: ARIAS LOPEZ JOAQUIN SECUNDINO. Nombramientos. Apoderado: ARIAS PAREDES ANTONIO.Datos registrales. T 3312 , F 142, S 8, H A 112872, I/A 6 (26.04.10).