Buscador CIF Logo

Actos BORME Sucesores De A Cadarso Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sucesores De A Cadarso Sl

Actos BORME Sucesores De A Cadarso Sl - B61923223

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Sucesores De A Cadarso Sl con CIF B61923223

馃敊 Perfil de Sucesores De A Cadarso Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Sucesores De A Cadarso Sl

30 de Diciembre de 2020
Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: JAC SUPRAHOLDING SL. TISARA 2015 SL. DRAGO PREMIA SL.Extinci贸n. Datos registrales. T 42212 , F 209, S 8, H B 194916, I/A 37 (21.12.20).

10 de Junio de 2019
Cambio de domicilio social. AV DIAGONAL NUM.463 BIS P.7 (BARCELONA). Datos registrales. T 42212 , F 208, S 8, H B194916, I/A 36 (31.05.19).

04 de Enero de 2018
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. AUDT.CTS.CON: PONT MESTRES &AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42212 , F 208, S 8, H B 194916, I/A 35 (22.12.17).

09 de Diciembre de 2016
Modificaciones estatutarias. ADICION DEL ARTICULO 9 BIS A LOS ESTATUTOS SOCIALES. TRANSMISION INDIRECTA DE LASPARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 42212 , F 208, S 8, H B 194916, I/A 34 (29.11.16).

23 de Diciembre de 2015
Escisi贸n parcial. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: TISARA 2015 SL. DRAGO PREMIA SL. JAC SUPRAHOLDING SL. Datosregistrales. T 42212 , F 207, S 8, H B 194916, I/A 33 (15.12.15).

23 de Marzo de 2015
Revocaciones. CONSEJERO: GOMEZ VALDEMOROS JULIA. PRESIDENTE: GOMEZ VALDEMOROS JULIA. CONSEJERO:CADARSO GOMEZ MIGUEL ANGEL. VICEPRESIDEN: CADARSO GOMEZ MIGUEL ANGEL. CONS. DELEG.: CADARSO GOMEZMIGUEL ANGEL. CONSEJERO: CADARSO GOMEZ JOSE ANTONIO. CONS. DELEG.: CADARSO GOMEZ JOSE ANTONIO.CONSEJERO: CADARSO GOMEZ INMACULADA. CONS. DELEG.: CADARSO GOMEZ INMACULADA. SE.TEC.NO CO: PEREZORTIZ CARLOS. Nombramientos. CONSEJERO: IC SUBHOLDING 2014 SL. REPR.143 RRM: CADARSO GOMEZ INMACULADA.CONS.DEL.MAN: IC SUBHOLDING 2014 SL. CONSEJERO: JAC SUBHOLDING SL. PRESIDENTE: JAC SUBHOLDING SL.CONS.DEL.MAN: JAC SUBHOLDING SL. REPR.143 RRM: CADARSO GOMEZ JOSE ANTONIO. CONSEJERO: DRAGO PREMIASL. CONS.DEL.MAN: DRAGO PREMIA SL. REPR.143 RRM: CADARSO GOMEZ MIGUEL ANGEL. SECR.NO CONS: PEREZ ORTIZCARLOS. Datos registrales. T 42212 , F 206, S 8, H B 194916, I/A 32 (13.03.15).

30 de Octubre de 2014
Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES & AUDITORES ASOCIADOS SA. AUDT.CTS.CON: PONT MESTRES &AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42212 , F 206, S 8, H B 194916, I/A 31 (23.10.14).

11 de Abril de 2014
Revocaciones. APODERADO: CASCANTE SERRATOSA CARLOS. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MOREU PEREZPEDRERO FRANCESC;CASTILLO DIAZ ANTONIO JOAQUIN. APOD.MANCOMU: CADARSO GOMEZ MIGUEL ANGEL;CADARSOGOMEZ JOSE ANTONIO;CADARSO GOMEZ INMACULADA;CADARSO FONT MIGUEL ANGEL;CADARSO PUJADASMONICA;CARRE脩O CADARSO JAIME. Datos registrales. T 42212 , F 205, S 8, H B 194916, I/A 30 ( 3.04.14).

18 de Abril de 2013
Ampliaci贸n de capital. Capital: 37.419,52 Euros. Resultante Suscrito: 634.447,36 Euros. Datos registrales. T 42212 , F 204, S 8, HB 194916, I/A 29 ( 9.04.13).

26 de Diciembre de 2012
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.925,12 Euros. Resultante Suscrito: 597.027,84 Euros. Datos registrales. T 42212 , F203, S 8, H B 194916, I/A 28 (18.12.12).

27 de Diciembre de 2011
Nombramientos. AUDT.CTS.CON: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42212 , F 203, S 8, H B194916, I/A 26 (16.12.11).

Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PONT MESTRES Y AUDITORES ASOCIADOS SA. Datos registrales. T 42212 , F 203, S 8, H B194916, I/A 27 (16.12.11).

08 de Agosto de 2011
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.346,24 Euros. Resultante Suscrito: 598.952,96 Euros. Datos registrales. T 42212 , F201, S 8, H B 194916, I/A 25 (28.07.11).

20 de Diciembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 18.408,96 Euros. Resultante Suscrito: 601.299,20 Euros. Datos registrales. T 35206 , F 69, S 8, H B194916, I/A 24 ( 7.12.10).

16 de Julio de 2010
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.985,28 Euros. Resultante Suscrito: 582.890,24 Euros. Datos registrales. T 35206 , F 67,S 8, H B 194916, I/A 23 ( 6.07.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n