Buscador CIF Logo

Actos BORME Suelo Industrial De Cantabria SL

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Suelo Industrial De Cantabria SL

Actos BORME Suelo Industrial De Cantabria SL - B39450986

Tenemos registrados 57 Actos BORME del Registro Mercantil de Cantabria para Suelo Industrial De Cantabria SL con CIF B39450986

馃敊 Perfil de Suelo Industrial De Cantabria SL
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Cantabria

Actos BORME de Suelo Industrial De Cantabria SL

24 de Noviembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: SAN EMETERIO HUIDOBRO EZEQUIEL. Datos registrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 70(15.11.23).

20 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-OLIVA MASCAROS MANUEL. Revocaciones. Apoderado: BOCANEGRA DIEGOANTONIO. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: ROIZ LOPEZ GONZALO. Datosregistrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 68 (13.10.23).

Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROIZ LOPEZ GONZALO. Nombramientos. SecreNoConsj: LABAT ESCALANTE PEDRO.Datos registrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 69 (13.10.23).

15 de Septiembre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: PI脩EIRO GARCIA-LAGO MODESTO;DIESTRO EGUREN PABLO;MUNARRIZ PALAZUELOSENRIQUE;LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Presidente: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ALVEARPORTILLA MANUEL-DANIEL;DE BERRAZUETA SANCHEZ DE VEGA MONICA;PEREZ TEZANOS RAFAELFERNANDO;RODRIGUEZ OTERO ALFREDO. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: ARISTI BARCA EDUARDO. Consejero: ARISTI BARCA EDUARDO;DASGOAS RODRIGUEZTOMAS;GOMEZ VAZQUEZ TERESA;CARAMES LUENGO CARLOS ALBERTO;CEBALLOS PEREDA JOSE LUIS;PEDRAJA TERANANGEL;PUENTE REDONDO JAVIER;GONZALEZ PESCADOR ANA-MARIA;LOPEZ SOTO OSCAR. Apo.Sol.: CEBALLOS PEREDAJOSE LUIS. Presidente: ARISTI BARCA EDUARDO. Otros conceptos: El Consejo de Administraci贸n pasa a estar compuesto porONCE miembros. Datos registrales. T 1175 , F 161, S 8, H S 9731, I/A 67 ( 7.09.23).

02 de Diciembre de 2022
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-RIANCHO PASTOR SARA. Datos registrales. T 1175 , F 160, S 8, H S 9731, I/A 66(23.11.22).

28 de Octubre de 2022
Otros conceptos: Sustituci贸n de don Javier Garc铆a Esperanza por don JOSE MARCOS FERNANDEZ LOPEZ como representantepersona f铆sica del Consejero "PE脩A RUEDA, S.L.". Datos registrales. T 1175 , F 160, S 8, H S 9731, I/A 65 (20.10.22).

12 de Agosto de 2022
Modificaciones estatutarias. Se adiciona el art. 5 bis) de los estatutos relativo a las comunicaciones entre socios y administradorespor medios telem谩ticos.. Se modifica el art. 18 de los estatutos relativo al 贸rgano convocante de la junta.. Se modifica el art. 20 de losestatutos relativo a la forma de convoctoria de la junta.. Se adiciona el art. 20 bis) de los estatutos posibilitando la asistencia a la juntapor video conferencia u otros medios telem谩ticos.. Se modifica el art. 22 de los estatutos relativo a la representaci贸n en las juntas. . Seadiciona el art. 22 bis) de los estatutos relativo al voto a distancia anticipado en las juntas.. Se modifica el art. 30 de los estatutosrelativo al Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 64 ( 2.08.22).

17 de Febrero de 2022
Nombramientos. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 63 (8.02.22).

07 de Octubre de 2021
Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ OTERO ALFREDO. Otros conceptos: Con el nuevo nombramiento acordado, el n煤merode miembros del Consejo de Administraci贸n queda FIJADO en DIEZ. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 62 (1.10.21).

30 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRION MALO JAVIER. Nombramientos. Consejero: PEREZ TEZANOS RAFAEL. Datosregistrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 61 (19.07.21).

26 de Marzo de 2021
Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GALLEGO FRANCISCO LUIS;PELAYO PARDO RAUL. Presidente: MARTIN GALLEGOFRANCISCO LUIS. Revocaciones. Apoderado: MARTIN GALLEGO FRANCISCO LUIS. Apo.Sol.: PELAYO PARDO RAUL.Nombramientos. Consejero: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Presidente: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER.Consejero: ALVEAR PORTILLA MANUEL-DANIEL. Apoderado: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Consejero: DEBERRAZUETA SANCHEZ DE VEGA MONICA. Otros conceptos: El Consejo de Administraci贸n pasa a estar formado y compuestopor nueve miembros.- Datos registrales. T 1175 , F 158, S 8, H S 9731, I/A 60 (15.03.21).

25 de Febrero de 2021
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.699.962,54 Euros. Resultante Suscrito: 30.175.794,18 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 158, S8, H S 9731, I/A 59 (11.02.21).

05 de Marzo de 2020
Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRILES EDESA ROSENDO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-OLIVA MASCAROSMANUEL. Datos registrales. T 1175 , F 157, S 8, H S 9731, I/A 58 (24.02.20).

20 de Enero de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRUZ VIADERO JOSE MANUEL;IZAGUIRRE ARANCETA ORENCIO ALFREDO;AMORRORTUARRESE ICIAR. Nombramientos. Consejero: MUNARRIZ PALAZUELOS ENRIQUE;CARRION MALO JAVIER;LOPEZ ESTRADAJAVIER. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 55 (10.01.20).

Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.999.861,44 Euros. Resultante Suscrito: 25.475.831,64 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 156, S8, H S 9731, I/A 56 (10.01.20).

Nombramientos. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 157, S 8, H S 9731, I/A 57 (10.01.20).

26 de Septiembre de 2019
Revocaciones. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 54 (19.09.19).

04 de Enero de 2019
Nombramientos. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 53 (27.12.18).

24 de Diciembre de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.719.784,49 Euros. Resultante Suscrito: 20.475.970,20 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 155, S8, H S 9731, I/A 52 (17.12.18).

25 de Octubre de 2018
Nombramientos. Apoderado: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731, I/A 51 (15.10.18).

21 de Febrero de 2018
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.499.869,87 Euros. Resultante Suscrito: 14.756.185,71 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 182, S8, H S 9731, I/A 48 (12.02.18).

Otros conceptos: Sustituci贸n de D. Jos茅 Antonio Hoz Montes por D. JAVIER GARCIA ESPERANZA con DNI/NIF n煤mero02214100M como representante persona f铆sica del consejero "PE脩A RUEDA SL".- Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731,I/A 49 (12.02.18).

Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO GARCIA SALVADOR. Nombramientos. Consejero: AMORRORTU ARRESE ICIAR.Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731, I/A 50 (12.02.18).

19 de Septiembre de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.724.876,89 Euros. Resultante Suscrito: 11.256.315,84 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 182, S8, H S 9731, I/A 47 ( 6.09.17).

07 de Diciembre de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.378.916,17 Euros. Resultante Suscrito: 7.531.438,95 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 181, S8, H S 9731, I/A 46 (28.11.16).

11 de Agosto de 2016
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.378.858,84 Euros. Resultante Suscrito: 4.152.522,78 Euros. Datos registrales. T 1054 ,F 181, S 8, H S 9731, I/A 45 ( 2.08.16).

10 de Agosto de 2016
Ampliacion del objeto social. El an谩lisis, planificaci贸n, promoci贸n y fomento del desarrollo de la industria, la energia, las energiasrenovables y la eficiencia energ茅tica.- Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 44 ( 1.08.16).

31 de Mayo de 2016
Otros conceptos: Se cesa a Do帽a Mar铆a-Teresa Rod谩n Cartiel como representante persona f铆sica de PE脩A RUEDA, SL y se nombraen su lugar a Don JOSE-ANTONIO HOZ MONTES. Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 43 (23.05.16).

17 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Auditor: ABOLL AUDITORES S L P. Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 42 ( 7.12.15).

12 de Noviembre de 2015
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.378.934,44 Euros. Resultante Suscrito: 7.531.381,62 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 180, S8, H S 9731, I/A 41 ( 3.11.15).

22 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Presidente: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO.Consejero: CALDERON CIRIZA ILDEFONSO;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO;RUIZ PEREZ ROSENDO. Con.Delegado:FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO;HERNANDEZ PRIETO

Nombramientos. Consejero: CRUZ VIADERO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T1054 , F 180, S 8, H S 9731, I/A 40 (15.10.15).

13 de Marzo de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 36 ( 5.03.15).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 37 ( 5.03.15).

Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Nombramientos. Con.Delegado: FERNANDEZGONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 38 ( 5.03.15).

19 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ PUERTAS FERNANDO JAVIER. Nombramientos. Consejero: RUIZ PEREZROSENDO. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 35 (12.12.13).

11 de Diciembre de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONESJESUS;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZANDREA;PEDRAJA TERAN ANGEL;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 34 (2.12.13).

04 de Septiembre de 2013
Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 33(29.08.13).

06 de Agosto de 2013
Ampliacion del objeto social. Promoci贸n, construcci贸n, operaci贸n, mantenimiento y gesti贸n de instalaciones de producci贸n y ventade energ铆a el茅ctrica, incluy茅ndose entre ellas, a modo enunciativo y no exhaustivo, las de producci贸n e贸lica, solar, solar t茅rmica, solarfotovolt谩ica y biomasa. Cambio de domicilio social. C/ ISABEL TORRES, N潞 1, PARQUE CIENTIFICO Y TECNOL (SANTANDER).Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 32 (29.07.13).

24 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 965 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 31 (15.05.13).

16 de Mayo de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS;PEREZ GONZALEZ ANDREA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO.Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 30 ( 8.05.13).

15 de Marzo de 2013
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CABETAS GARCIA MIGUEL. Consejero: CABETAS GARCIA MIGUEL. Nombramientos.Con.Delegado: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 29 ( 7.03.13).

11 de Marzo de 2013
Nombramientos. Consejero: CALDERON CIRIZA ILDEFONSO. Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 27 ( 4.03.13).

Cambio de domicilio social. C/ ALBERT EINSTEIN, N潞 4. PARQUE CIENTIFICO Y TECN (SANTANDER). Datos registrales. T 965, F 41, S 8, H S 9731, I/A 28 ( 4.03.13).

29 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ ANDREA;ABAD MARTIN FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS. Datos registrales. T 965 , F 40, S 8, H S 9731, I/A 26 (18.10.12).

13 de Septiembre de 2012
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA S L. SUELO INDUSTRIAL DE SAMANO2006 SL. Datos registrales. T 965 , F 40, S 8, H S 9731, I/A 25 ( 3.09.12).

07 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA. Nombramientos. Consejero: PE脩A RUEDA SL.Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 24 (23.07.12).

01 de Agosto de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 22 (23.07.12).

Revocaciones. Apo.Sol.: GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE;ORTIZ GOMEZ PATRICIA;HERNANDEZ PRIETOVICTOR;OTERO BALLESTEROS MARIA;GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE. Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S9731, I/A 23 (23.07.12).

01 de Junio de 2012
Revocaciones. Auditor: CAMBLOR & JAMESON S.L.L. Nombramientos. Auditor: ABOLL AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 21 (22.05.12).

05 de Enero de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABAD MARTIN FRANCISCO-JAVIER;PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 965 , F38, S 8, H S 9731, I/A 20 (27.12.11).

13 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Auditor: CAMBLOR & JAMESON S.L.L. Datos registrales. T 965 , F 38, S 8, H S 9731, I/A 19 (30.11.11).

04 de Octubre de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDRO OBREGON CAGIGAS;ORTIZ GOMEZ PATRICIA. Con.Delegado: VALLE SOTO VICTORJOSE. Presidente: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Revocaciones. Secretario: FRANCISCO JAVIER PE脩A ZAVALA.Nombramientos. Secretario: CARRILES EDESA ROSENDO. Consejero: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO;PEREZGONZALEZ ANDREA;CABETAS GARCIA MIGUEL;RODRIGUEZ PUERTAS FERNANDO JAVIER. Presidente: ARASTI BARCAEDUARDO CARMELO. Con.Delegado: CABETAS GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 18(22.09.11).

18 de Noviembre de 2010
Nombramientos. Apo.Sol.: GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 17 (8.11.10).

27 de Septiembre de 2010
Cambio de domicilio social. C/ ISABEL TORRES. PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (SANTANDER). Datos registrales. T965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 16 (14.09.10).

09 de Agosto de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL OLMO ILARZA FRANCISCO JAVIER. Presidente: DEL OLMO ILARZA FRANCISCO JAVIER.Consejero: ANTU脩ANO HELQUERA JOAQUIN;VILLAESCUSA CARRANZA JOSE. Nombramientos. Consejero: ORTIZ GOMEZPATRICIA. Presidente: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 15 (27.07.10).

26 de Marzo de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 54,55 Euros. Resultante Suscrito: 4.152.447,18 Euros. Datos registrales. T 671 , F 183, S 8, H S9731, I/A 14 (21.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n