Actos BORME de Suelo Industrial De Cantabria SL
24 de Noviembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: SAN EMETERIO HUIDOBRO EZEQUIEL. Datos registrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 70(15.11.23).
20 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: GARCIA-OLIVA MASCAROS MANUEL. Revocaciones. Apoderado: BOCANEGRA DIEGOANTONIO. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj: ROIZ LOPEZ GONZALO. Datosregistrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 68 (13.10.23).
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: ROIZ LOPEZ GONZALO. Nombramientos. SecreNoConsj: LABAT ESCALANTE PEDRO.Datos registrales. T 1303 , F 103, S 8, H S 9731, I/A 69 (13.10.23).
15 de Septiembre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: PI脩EIRO GARCIA-LAGO MODESTO;DIESTRO EGUREN PABLO;MUNARRIZ PALAZUELOSENRIQUE;LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Presidente: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Consejero: ALVEARPORTILLA MANUEL-DANIEL;DE BERRAZUETA SANCHEZ DE VEGA MONICA;PEREZ TEZANOS RAFAELFERNANDO;RODRIGUEZ OTERO ALFREDO. Revocaciones. Apoderado: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER.Nombramientos. Apoderado: ARISTI BARCA EDUARDO. Consejero: ARISTI BARCA EDUARDO;DASGOAS RODRIGUEZTOMAS;GOMEZ VAZQUEZ TERESA;CARAMES LUENGO CARLOS ALBERTO;CEBALLOS PEREDA JOSE LUIS;PEDRAJA TERANANGEL;PUENTE REDONDO JAVIER;GONZALEZ PESCADOR ANA-MARIA;LOPEZ SOTO OSCAR. Apo.Sol.: CEBALLOS PEREDAJOSE LUIS. Presidente: ARISTI BARCA EDUARDO. Otros conceptos: El Consejo de Administraci贸n pasa a estar compuesto porONCE miembros. Datos registrales. T 1175 , F 161, S 8, H S 9731, I/A 67 ( 7.09.23).
02 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ-RIANCHO PASTOR SARA. Datos registrales. T 1175 , F 160, S 8, H S 9731, I/A 66(23.11.22).
28 de Octubre de 2022Otros conceptos: Sustituci贸n de don Javier Garc铆a Esperanza por don JOSE MARCOS FERNANDEZ LOPEZ como representantepersona f铆sica del Consejero "PE脩A RUEDA, S.L.". Datos registrales. T 1175 , F 160, S 8, H S 9731, I/A 65 (20.10.22).
12 de Agosto de 2022Modificaciones estatutarias. Se adiciona el art. 5 bis) de los estatutos relativo a las comunicaciones entre socios y administradorespor medios telem谩ticos.. Se modifica el art. 18 de los estatutos relativo al 贸rgano convocante de la junta.. Se modifica el art. 20 de losestatutos relativo a la forma de convoctoria de la junta.. Se adiciona el art. 20 bis) de los estatutos posibilitando la asistencia a la juntapor video conferencia u otros medios telem谩ticos.. Se modifica el art. 22 de los estatutos relativo a la representaci贸n en las juntas. . Seadiciona el art. 22 bis) de los estatutos relativo al voto a distancia anticipado en las juntas.. Se modifica el art. 30 de los estatutosrelativo al Consejo de Administraci贸n.. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 64 ( 2.08.22).
17 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: NORTE AUDITORES Y ASESORES SL. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 63 (8.02.22).
07 de Octubre de 2021Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ OTERO ALFREDO. Otros conceptos: Con el nuevo nombramiento acordado, el n煤merode miembros del Consejo de Administraci贸n queda FIJADO en DIEZ. Datos registrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 62 (1.10.21).
30 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: CARRION MALO JAVIER. Nombramientos. Consejero: PEREZ TEZANOS RAFAEL. Datosregistrales. T 1175 , F 159, S 8, H S 9731, I/A 61 (19.07.21).
26 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN GALLEGO FRANCISCO LUIS;PELAYO PARDO RAUL. Presidente: MARTIN GALLEGOFRANCISCO LUIS. Revocaciones. Apoderado: MARTIN GALLEGO FRANCISCO LUIS. Apo.Sol.: PELAYO PARDO RAUL.Nombramientos. Consejero: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Presidente: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER.Consejero: ALVEAR PORTILLA MANUEL-DANIEL. Apoderado: LOPEZ MARCANO FRANCISCO JAVIER. Consejero: DEBERRAZUETA SANCHEZ DE VEGA MONICA. Otros conceptos: El Consejo de Administraci贸n pasa a estar formado y compuestopor nueve miembros.- Datos registrales. T 1175 , F 158, S 8, H S 9731, I/A 60 (15.03.21).
25 de Febrero de 2021Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.699.962,54 Euros. Resultante Suscrito: 30.175.794,18 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 158, S8, H S 9731, I/A 59 (11.02.21).
05 de Marzo de 2020Ceses/Dimisiones. Secretario: CARRILES EDESA ROSENDO. Nombramientos. SecreNoConsj: GARCIA-OLIVA MASCAROSMANUEL. Datos registrales. T 1175 , F 157, S 8, H S 9731, I/A 58 (24.02.20).
20 de Enero de 2020Ceses/Dimisiones. Consejero: CRUZ VIADERO JOSE MANUEL;IZAGUIRRE ARANCETA ORENCIO ALFREDO;AMORRORTUARRESE ICIAR. Nombramientos. Consejero: MUNARRIZ PALAZUELOS ENRIQUE;CARRION MALO JAVIER;LOPEZ ESTRADAJAVIER. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 55 (10.01.20).
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.999.861,44 Euros. Resultante Suscrito: 25.475.831,64 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 156, S8, H S 9731, I/A 56 (10.01.20).
Nombramientos. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 157, S 8, H S 9731, I/A 57 (10.01.20).
26 de Septiembre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 54 (19.09.19).
04 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: BRAINSTORMING AUDIT SLP. Datos registrales. T 1175 , F 156, S 8, H S 9731, I/A 53 (27.12.18).
24 de Diciembre de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 5.719.784,49 Euros. Resultante Suscrito: 20.475.970,20 Euros. Datos registrales. T 1175 , F 155, S8, H S 9731, I/A 52 (17.12.18).
25 de Octubre de 2018Nombramientos. Apoderado: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731, I/A 51 (15.10.18).
21 de Febrero de 2018Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.499.869,87 Euros. Resultante Suscrito: 14.756.185,71 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 182, S8, H S 9731, I/A 48 (12.02.18).
Otros conceptos: Sustituci贸n de D. Jos茅 Antonio Hoz Montes por D. JAVIER GARCIA ESPERANZA con DNI/NIF n煤mero02214100M como representante persona f铆sica del consejero "PE脩A RUEDA SL".- Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731,I/A 49 (12.02.18).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BLANCO GARCIA SALVADOR. Nombramientos. Consejero: AMORRORTU ARRESE ICIAR.Datos registrales. T 1175 , F 155, S 8, H S 9731, I/A 50 (12.02.18).
19 de Septiembre de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.724.876,89 Euros. Resultante Suscrito: 11.256.315,84 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 182, S8, H S 9731, I/A 47 ( 6.09.17).
07 de Diciembre de 2016Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.378.916,17 Euros. Resultante Suscrito: 7.531.438,95 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 181, S8, H S 9731, I/A 46 (28.11.16).
11 de Agosto de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 3.378.858,84 Euros. Resultante Suscrito: 4.152.522,78 Euros. Datos registrales. T 1054 ,F 181, S 8, H S 9731, I/A 45 ( 2.08.16).
10 de Agosto de 2016Ampliacion del objeto social. El an谩lisis, planificaci贸n, promoci贸n y fomento del desarrollo de la industria, la energia, las energiasrenovables y la eficiencia energ茅tica.- Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 44 ( 1.08.16).
31 de Mayo de 2016Otros conceptos: Se cesa a Do帽a Mar铆a-Teresa Rod谩n Cartiel como representante persona f铆sica de PE脩A RUEDA, SL y se nombraen su lugar a Don JOSE-ANTONIO HOZ MONTES. Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 43 (23.05.16).
17 de Diciembre de 2015Nombramientos. Auditor: ABOLL AUDITORES S L P. Datos registrales. T 1054 , F 181, S 8, H S 9731, I/A 42 ( 7.12.15).
12 de Noviembre de 2015Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.378.934,44 Euros. Resultante Suscrito: 7.531.381,62 Euros. Datos registrales. T 1054 , F 180, S8, H S 9731, I/A 41 ( 3.11.15).
22 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Presidente: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO.Consejero: CALDERON CIRIZA ILDEFONSO;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO;RUIZ PEREZ ROSENDO. Con.Delegado:FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO;HERNANDEZ PRIETO
Nombramientos. Consejero: CRUZ VIADERO JOSE MANUEL. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T1054 , F 180, S 8, H S 9731, I/A 40 (15.10.15).
13 de Marzo de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 36 ( 5.03.15).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 37 ( 5.03.15).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Nombramientos. Con.Delegado: FERNANDEZGONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 38 ( 5.03.15).
19 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ PUERTAS FERNANDO JAVIER. Nombramientos. Consejero: RUIZ PEREZROSENDO. Datos registrales. T 1054 , F 178, S 8, H S 9731, I/A 35 (12.12.13).
11 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONESJESUS;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZANDREA;PEDRAJA TERAN ANGEL;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 34 (2.12.13).
04 de Septiembre de 2013Nombramientos. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 33(29.08.13).
06 de Agosto de 2013Ampliacion del objeto social. Promoci贸n, construcci贸n, operaci贸n, mantenimiento y gesti贸n de instalaciones de producci贸n y ventade energ铆a el茅ctrica, incluy茅ndose entre ellas, a modo enunciativo y no exhaustivo, las de producci贸n e贸lica, solar, solar t茅rmica, solarfotovolt谩ica y biomasa. Cambio de domicilio social. C/ ISABEL TORRES, N潞 1, PARQUE CIENTIFICO Y TECNOL (SANTANDER).Datos registrales. T 1054 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 32 (29.07.13).
24 de Mayo de 2013Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 965 , F 177, S 8, H S 9731, I/A 31 (15.05.13).
16 de Mayo de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS;PEREZ GONZALEZ ANDREA. Nombramientos. Apo.Man.Soli:MEDIA SAINZ ROBERTO;PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS;FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO.Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 30 ( 8.05.13).
15 de Marzo de 2013Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: CABETAS GARCIA MIGUEL. Consejero: CABETAS GARCIA MIGUEL. Nombramientos.Con.Delegado: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO. Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 29 ( 7.03.13).
11 de Marzo de 2013Nombramientos. Consejero: CALDERON CIRIZA ILDEFONSO. Datos registrales. T 965 , F 41, S 8, H S 9731, I/A 27 ( 4.03.13).
Cambio de domicilio social. C/ ALBERT EINSTEIN, N潞 4. PARQUE CIENTIFICO Y TECN (SANTANDER). Datos registrales. T 965, F 41, S 8, H S 9731, I/A 28 ( 4.03.13).
29 de Octubre de 2012Revocaciones. Apo.Man.Soli: PEREZ GONZALEZ ANDREA;ABAD MARTIN FRANCISCO-JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli:PEREZ GONZALEZ ANDREA;DE LAS CUEVAS BRIONES JESUS. Datos registrales. T 965 , F 40, S 8, H S 9731, I/A 26 (18.10.12).
13 de Septiembre de 2012Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SUELO INDUSTRIAL DE TORRELAVEGA S L. SUELO INDUSTRIAL DE SAMANO2006 SL. Datos registrales. T 965 , F 40, S 8, H S 9731, I/A 25 ( 3.09.12).
07 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GUTIERREZ RODRIGUEZ ALFONSO MARIA. Nombramientos. Consejero: PE脩A RUEDA SL.Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 24 (23.07.12).
01 de Agosto de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 22 (23.07.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE;ORTIZ GOMEZ PATRICIA;HERNANDEZ PRIETOVICTOR;OTERO BALLESTEROS MARIA;GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE. Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S9731, I/A 23 (23.07.12).
01 de Junio de 2012Revocaciones. Auditor: CAMBLOR & JAMESON S.L.L. Nombramientos. Auditor: ABOLL AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA.Datos registrales. T 965 , F 39, S 8, H S 9731, I/A 21 (22.05.12).
05 de Enero de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABAD MARTIN FRANCISCO-JAVIER;PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 965 , F38, S 8, H S 9731, I/A 20 (27.12.11).
13 de Diciembre de 2011Nombramientos. Auditor: CAMBLOR & JAMESON S.L.L. Datos registrales. T 965 , F 38, S 8, H S 9731, I/A 19 (30.11.11).
04 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: PEDRO OBREGON CAGIGAS;ORTIZ GOMEZ PATRICIA. Con.Delegado: VALLE SOTO VICTORJOSE. Presidente: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Revocaciones. Secretario: FRANCISCO JAVIER PE脩A ZAVALA.Nombramientos. Secretario: CARRILES EDESA ROSENDO. Consejero: ARASTI BARCA EDUARDO CARMELO;PEREZGONZALEZ ANDREA;CABETAS GARCIA MIGUEL;RODRIGUEZ PUERTAS FERNANDO JAVIER. Presidente: ARASTI BARCAEDUARDO CARMELO. Con.Delegado: CABETAS GARCIA MIGUEL. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 18(22.09.11).
18 de Noviembre de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: GOBANTES SAN EMETERIO JESUS BERNABE. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 17 (8.11.10).
27 de Septiembre de 2010Cambio de domicilio social. C/ ISABEL TORRES. PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO (SANTANDER). Datos registrales. T965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 16 (14.09.10).
09 de Agosto de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: DEL OLMO ILARZA FRANCISCO JAVIER. Presidente: DEL OLMO ILARZA FRANCISCO JAVIER.Consejero: ANTU脩ANO HELQUERA JOAQUIN;VILLAESCUSA CARRANZA JOSE. Nombramientos. Consejero: ORTIZ GOMEZPATRICIA. Presidente: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Datos registrales. T 965 , F 37, S 8, H S 9731, I/A 15 (27.07.10).
26 de Marzo de 2009Ampliaci贸n de capital. Capital: 54,55 Euros. Resultante Suscrito: 4.152.447,18 Euros. Datos registrales. T 671 , F 183, S 8, H S9731, I/A 14 (21.01.09).