Actos BORME de Suelo Industrial De Marina Y Medio Cudeyo 2006 Sl
30 de Marzo de 2023Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1268 , F 111, S 8, H S 18358, I/A 34(22.03.23).
12 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO;PEREZ PALAZUELOS EVA;DE MIGUEL GARCIA JUAN. Datosregistrales. T 1268 , F 111, S 8, H S 18358, I/A 33 (28.11.22).
17 de Febrero de 2022Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 32(10.02.22).
22 de Marzo de 2021Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Consejero: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Presidente:BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 31 ( 8.03.21).
26 de Febrero de 2020Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 30(17.02.20).
05 de Febrero de 2020Nombramientos. Apoderado: SAN VICENTE SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 29(29.01.20).
15 de Octubre de 2019Reelecciones. Consejero: MANERO ARDERIU ENRIQUE. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 27 ( 3.10.19).
Reelecciones. Consejero: PEREZ PALAZUELOS EVA;DE MIGUEL GARCIA JUAN;BURGADA PALLEIRO PEDRO;GONZALEZPORTILLA ROBERTO. Datos registrales. T 949 , F 225, S 8, H S 18358, I/A 28 ( 3.10.19).
20 de Diciembre de 2018Reelecciones. Auditor: ENRIQUE CAMPOS & AUDITORES SLP. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 26(13.12.18).
24 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: SAN VICENTE SUAREZ JOSE MANUEL. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 25(15.11.17).
17 de Abril de 2017Pérdida del caracter de unipersonalidad. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 24 ( 5.04.17).
21 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO.Nombramientos. Consejero: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 22 (15.04.16).
Nombramientos. Presidente: BOCANEGRA DIEGO ANTONIO. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 23 (15.04.16).
05 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Presidente: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Nombramientos.Consejero: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S 18358, I/A 20 (29.07.15).
Nombramientos. Presidente: FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO. Datos registrales. T 949 , F 224, S 8, H S 18358, I/A 21(29.07.15).
23 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ LAHUERTA LUIS MIGUEL. Nombramientos. Consejero: MANERO ARDERIU ENRIQUE.Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S 18358, I/A 18 (17.02.15).
Reelecciones. Consejero: PEREZ PALAZUELOS EVA;DE MIGUEL GARCIA JUAN;BURGADA PALLEIRO PEDRO;GONZALEZPORTILLA ROBERTO. Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S 18358, I/A 19 (17.02.15).
21 de Octubre de 2013Fe de erratas: Subsanación del acuerdo adoptado en la Junta General celebrada el 15 de diciembre de 2.011 en el sentido de que elnombramiento de doña Andrea Pérez González como consejera y Presidenta del Consejo lo es por plazo de cinco años y no portiempo indefinido.- Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S 18358, I/A 17 (14.10.13).
02 de Febrero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Presidente: VALLE SOTO VICTOR JOSE. Nombramientos.Consejero: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Presidente: PEREZ GONZALEZ ANDREA. Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S18358, I/A 15 (24.01.12).
Cambio de domicilio social. C/ ISABEL TORRES 1 (SANTANDER). Datos registrales. T 949 , F 223, S 8, H S 18358, I/A 16(24.01.12).