Buscador CIF Logo

Actos BORME Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima

Actos BORME Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima - A48022461

Tenemos registrados 35 Actos BORME del Registro Mercantil de Vizcaya para Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima con CIF A48022461

馃敊 Perfil de Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Vizcaya

Actos BORME de Suez Treatment Solutions Sociedad Anonima

06 de Abril de 2022
Ceses/Dimisiones. Consejero: OLMEDO CANO ISMAEL;BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Presidente: BONILLA BECKMANNJORGE ANGEL. Con.Delegado: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Consejero: RAMOS DE ARMAS FEDERICO. SecreNoConsj:MARTINEZ ZUBIAURRE RAMON. Nombramientos. Adm. Unico: OLMEDO CANO ISMAEL. Otros conceptos: Cambio del Organode Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administrador 煤nico. Datos registrales. T 6071 , F 152, S 8, H BI 3256,A , I/ 336.(29.03.22).

14 de Marzo de 2022
Revocaciones. Apoderado: SANCHEZ-RUIZ UNCETA BORJA. Datos registrales. T 5754 , F 224, S 8, H BI 3256,A , I/ 328 .(4.03.22).

Revocaciones. Apoderado: RIVAS HERNANDEZ CRISTINA;RIVAS HERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 5754 , F 225, S8, H BI 3256,A , I/ 329 .( 4.03.22).

Revocaciones. Apoderado: RIVAS HERNANDEZ CRISTINA;SANCHEZ-RUIZ UNCETA BORJA. Datos registrales. T 5754 , F 225,S 8, H BI 3256,A , I/ 330 .( 4.03.22).

Revocaciones. Apoderado: MARIN MORAZA EDUARDO. Datos registrales. T 5754 , F 225, S 8, H BI 3256,A , I/ 331 .( 4.03.22).

Revocaciones. Apoderado: DIEZ PONCE MARIANO FRANCISCO. Datos registrales. T 5754 , F 225, S 8, H BI 3256,A , I/ 332 .(4.03.22).

Ceses/Dimisiones. Consejero: HOULIE DIDIER MARIE. Nombramientos. Consejero: RAMOS DE ARMAS FEDERICO. Datosregistrales. T 5754 , F 225, S 8, H BI 3256,A , I/ 333 .( 4.03.22).

Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ZUBIAURRE RAMON. Datos registrales. T 5754 , F 225, S 8, H BI 3256,A , I/ 334 .(7.03.22).

Nombramientos. Apoderado: OLMEDO CANO ISMAEL. Datos registrales. T 6071 , F 152, S 8, H BI 3256,A , I/ 335 .( 7.03.22).

01 de Diciembre de 2021
Nombramientos. Apoderado: RUEDA VADILLO ROSA ANA. Datos registrales. T 5754 , F 223, S 8, H BI 3256,A , I/ 327 .(18.11.21).

21 de Mayo de 2021
Modificaci贸n de poderes. Apoderado: DE LA CALVA IBARRONDO IANIRE. Datos registrales. T 5754 , F 223, S 8, H BI 3256,A , I/326 .( 7.05.21).

29 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ROMEO GONZALEZ AVELINO. Apoderado: ROMEO GONZALEZ AVELINO;ROMEO GONZALEZAVELINO;ROMEO GONZALEZ AVELINO;ROMEO GONZALEZ AVELINO. Datos registrales. T 5754 , F 16, S 8, H BI 3256,A , I/ 323.(15.03.21).

Nombramientos. Apoderado: DE LA CALVA IBARRONDO IANIRE. Datos registrales. T 5754 , F 17, S 8, H BI 3256,A , I/ 324.(15.03.21).

Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5754 , F 17, S 8, H BI 3256,A , I/ 325.(16.03.21).

20 de Diciembre de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALEXANDRE JEAN LUC JACQUES. Nombramientos. Consejero: HOULIE DIDIER MARIE. Datosregistrales. T 5754 , F 16, S 8, H BI 3256,A , I/ 322 .(13.12.19).

03 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: AZCARATE GONZALEZ ANTONIO JESUS;BLAZQUEZ GUERRA JUAN CARLOS;GARCIA DE MIGUELJUAN IGNACIO;GONZALEZ CARRION JESUS;GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;DEL CAMPO PUENTE IGNACIO;KERAVELTHOMAS MARIE;VELASCO ALONSO JUAN MANUEL;DEL CAMPO PUENTE IGNACIO;BELTRAN RODRIGUEZFRANCISCO;MARINA VEGA GABRIEL;GALLEGO LONGAS JOSE BERNARDO;GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;AZCARATEGONZALEZ ANTONIO JESUS;BLAZQUEZ GUERRA JUAN CARLOS;KERAVEL THOMAS MARIE;DE CASTRO MELO JOAOMANUEL;GALLEGO LONGAS JOSE BERNARDO;MARIN MORAZA EDUARDO;MARTINEZ LATORRE LIBORIO;SANCHEZ BAZAN

26 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: MIQUEL ROMERA TERESA. Datos registrales. T 5754 , F 15, S 8, H BI 3256,A , I/ 320 .(16.11.18).

12 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: LARREA ALDAMA ELENA. Datos registrales. T 5754 , F 15, S 8, H BI 3256,A , I/ 319 .( 2.11.18).

11 de Octubre de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 5754 , F 15, S 8, H BI 3256,A , I/ 318.(28.09.18).

26 de Julio de 2018
Nombramientos. Apoderado: ORTIN BOTELLA MANUEL FRANCISCO. Datos registrales. T 5754 , F 10, S 8, H BI 3256,A , I/ 315.(16.07.18).

Nombramientos. Apoderado: REYES BAS FRANCISCO ANTONIO. Datos registrales. T 5754 , F 12, S 8, H BI 3256,A , I/ 316.(16.07.18).

Revocaciones. Apoderado: AZCARATE GONZALEZ ANTONIO. Datos registrales. T 5754 , F 15, S 8, H BI 3256,A , I/ 317.(16.07.18).

04 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: SUSAETA ELORRIAGA JOSE. Datos registrales. T 5754 , F 9, S 8, H BI 3256,A , I/ 314 .(20.04.18).

12 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: ALLENDE ARENAS JONE. Datos registrales. T 5509 , F 40, S 8, H BI 3256,A , I/ 312 .( 2.02.18).

Nombramientos. Apoderado: SALICIO NAVAS LAURA. Datos registrales. T 5509 , F 40, S 8, H BI 3256,A , I/ 313 .( 2.02.18).

Revocaciones. Apoderado: PIEDRA BUSTAMANTE IGNACIO VICTOR;MELO JOAO. Datos registrales. T 5754 , F 9, S 8, H BI3256,A , I/ 313 .( 2.02.18).

04 de Diciembre de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: HEDDESHEIMER STEPHANE. Presidente: GIROS CALPE ANA. Nombramientos. Consejero:OLMEDO CANO ISMAEL;ALEXANDRE JEAN LUC JACQUES. Presidente: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Con.Delegado:BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Reelecciones. Consejero: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Datos registrales. T5509 , F 39, S 8, H BI 3256,A , I/ 311 .(16.11.17).

25 de Octubre de 2017
Revocaciones. Apoderado: BLAZQUEZ GUERRA JUAN CARLOS;MARINA VEGA GABRIEL. Datos registrales. T 5509 , F 39, S 8,H BI 3256,A , I/ 310 .(13.10.17).

14 de Septiembre de 2017
Nombramientos. Apoderado: CARBONERO RODRIGUEZ CARRE脩O GUILLERMO. Datos registrales. T 5509 , F 34, S 8, H BI3256,A , I/ 309 .( 7.09.17).

15 de Marzo de 2017
Revocaciones. Apoderado: KERAVEL THOMAS MARIE;ICAZA DE LA PE脩A GONZALO. Datos registrales. T 5509 , F 34, S 8, H BI3256,A , I/ 308 .( 7.03.17).

06 de Marzo de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Con.Delegado: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO.Nombramientos. Consejero: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Con.Delegado: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Datosregistrales. T 5509 , F 33, S 8, H BI 3256,A , I/ 307 .(21.02.17).

05 de Diciembre de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SUEZ ENVIRONNMENT ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero: GIROSCALPE ANA;GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO;HEDDESHEIMER STEPHANE. Presidente: GIROS CALPE ANA. SecreNoConsj:MARTINEZ ZUBIAURRE RAMON. Con.Delegado: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 5509 , F 29, S 8, H BI 3256,A , I/ 303.(25.11.16).

Nombramientos. Apoderado: BONILLA BECKMANN JORGE ANGEL. Datos registrales. T 5509 , F 30, S 8, H BI 3256,A , I/ 305.(25.11.16).

Revocaciones. Apoderado: GARCIA DE MIGUEL JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 5509 , F 29, S 8, H BI 3256,A , I/ 304.(25.11.16).

Nombramientos. Apoderado: RIVAS HERNANDEZ CRISTINA. Datos registrales. T 5509 , F 32, S 8, H BI 3256,A , I/ 306.(25.11.16).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n