Actos BORME de Suip Infonegocio Sl
30 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 7 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 41353 , F 48, S 8, H M 732981, I/A 6 (15.12.22).
18 de Noviembre de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SONNEDIX OMICRON SL. Datos registrales. T 41353 , F 47, S 8, HM 732981, I/A 5 (11.11.21).
06 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE. Datosregistrales. T 41353 , F 47, S 8, H M 732981, I/A 4 (28.04.21).
04 de Mayo de 2021Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE. Datosregistrales. T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 3 (26.04.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA, NUMERO 108, PLANTA 12 (MADRID).Datos registrales. T 41353 , F 46, S 8, H M 732981, I/A 2 (25.03.21).
26 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Manc.: VILLALBA CORTESJUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Datos registrales. T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 5(18.06.20).
22 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NORMANN MARC. Datosregistrales. T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 4 (13.05.20).
21 de Octubre de 2019Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD. Fe de erratas: Por error no se public贸 en el Bolet铆n 173 de fecha 07/09/18 y referencia03682742018 la revocaci贸n de D. Wicke Richard como apoderado. Datos registrales. T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V 179107, I/A 3(31.08.18).
07 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Apo.Sol.: KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 10403, L 7684, F 24, S 8, H V179107, I/A 3 (31.08.18).
19 de Diciembre de 2017Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR). Datos registrales. T 10403, L 7684, F24, S 8, H V 179107, I/A 2 (12.12.17).
23 de Febrero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 1163 , F 205, S 8, H L 23069, I/A 8 (10.02.17).
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Manc.: WICKERICHARD;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1163 , F 205, S 8, H L 23069, I/A 9 (10.02.17).
28 de Junio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GAARNLARSEN LARS CHRISTIAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1163 , F 8, S 8, H L 23069, I/A 7 (16.06.16).
23 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN;FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA;GANDIA FORNES JOSELUIS. Datos registrales. T 1163 , F 4, S 8, H L 23069, I/A 6 (15.06.15).
22 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SEEM ERIC KRISTOFFER. Nombramientos. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN LARSENLARS CHRISTIAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 1163 , F 3, S 8, H L 23069, I/A 5 (12.11.12).
02 de Noviembre de 2009Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SEEM ERIC KRISTOFFER;ANDERSEN KLAUS RAFN. Nombramientos. Adm. Unico: SEEM ERICKRISTOFFER. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1163 , F 3, S 8, H L 23069, I/A 4 (21.10.09).