Buscador CIF Logo

Actos BORME Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa

Actos BORME Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa - A28388023

Tenemos registrados 21 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa con CIF A28388023

馃敊 Perfil de Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sulzer Pumps Wastewater Spain Sa

10 de Mayo de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: PATTEN CLIVE HUGH;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;LALANNE FREDERIC ARNAUD.Presidente: PATTEN CLIVE HUGH. Con.Delegado: PATTEN CLIVE HUGH. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO.Nombramientos. Consejero: JENSEN SOREN;BEGNER INGO;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Datos registrales. T 28912 , F149, S 8, H M 116866, I/A 95 ( 3.05.23).

Nombramientos. Presidente: JENSEN SOREN. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Con.Delegado: JENSEN SOREN.Datos registrales. T 28912 , F 149, S 8, H M 116866, I/A 96 ( 3.05.23).

30 de Noviembre de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 148, S 8, H M 116866, I/A 94 (23.11.22).

21 de Noviembre de 2022
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: NORDIC WATER TECNOLOGY IBERICA SL. Datos registrales. T 28912 , F 146, S8, H M 116866, I/A 93 (14.11.22).

10 de Junio de 2022
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 146, S 8, H M 116866, I/A 92 ( 5.06.22).

18 de Mayo de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: ALVAREZ GONZALEZ CARLOS-ALBERTO. Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ TADEO DANIEL.Datos registrales. T 28912 , F 145, S 8, H M 116866, I/A 91 (10.05.22).

14 de Junio de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 145, S 8, H M 116866, I/A 90 ( 7.06.21).

22 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apo.Sol.: DA SILVA FRADE MARTINS DE CARVALHO DIOGO MARIA. Datos registrales. T 28912 , F 145, S 8, HM 116866, I/A 89 (12.03.21).

05 de Junio de 2020
Ceses/Dimisiones. Consejero: COMAR ALESSANDRO;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Secretario: FRUHBECK OLMEDOGUILLERMO. Consejero: PATTEN CLIVE HUGH. Presidente: PATTEN CLIVE HUGH. Cons.Del.Sol: PATTEN CLIVE HUGH.Nombramientos. Consejero: PATTEN CLIVE HUGH;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;LALANNE FREDERIC ARNAUD.Presidente: PATTEN CLIVE HUGH. Con.Delegado: PATTEN CLIVE HUGH. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. L.Asesor: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 144, S

15 de Octubre de 2019
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 144, S 8, H M 116866, I/A 87 ( 8.10.19).

09 de Julio de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ GAGO JESUS;PEY LOPEZ JORGE;BARTOLOME GAMBOA LORENA. Datos registrales. T28912 , F 143, S 8, H M 116866, I/A 86 ( 2.07.18).

27 de Junio de 2018
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 143, S 8, H M 116866, I/A 85 (19.06.18).

04 de Mayo de 2017
Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTIN ESPINOSA EVA. Nombramientos. Apoderado: BARTOLOME GAMBOA LORENA. Datosregistrales. T 28912 , F 143, S 8, H M 116866, I/A 84 (25.04.17).

15 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: DA SILVA FRADE MARTINS DE CARVALHO DIOGO MARIA;FRUHBECK OLMEDOGUILLERMO;FRUHBECK BORRERO GUILLERMO;PEY LOPEZ JORGE;LOPEZ GAGO JESUS. Otros conceptos: Se estabelceuna sucursal en Portugal, por tiempo indefinido, bajo la denominaci贸n: "SULZER PUMPS WASTEWATER SPAIN S.A.U., Sucural enPortugal", con domicilio en Rua de Entre Muros, 54, N煤cleo Empresarial de S谩o Juli谩o do Tojal, Pavilh谩o AN, S谩o Juli谩o do Tojal,Loures, Portugal. Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SULZER PUMPS WASTEWATER PORTUGAL SA. Datosregistrales. T 28912 , F 140, S 8, H M 116866, I/A 83 ( 8.03.17).

10 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 139, S 8, H M 116866, I/A 82 (30.12.16).

06 de Octubre de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;HIRVENSALO MIKKO;COMAR ALESSANDRO. Presidente:HIRVENSALO MIKKO. Con.Delegado: HIRVENSALO MIKKO. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: COMAR ALESSANDRO;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Consejero:PATTEN CLIVE HUGH. Presidente: PATTEN CLIVE HUGH. Cons.Del.Sol: PATTEN CLIVE HUGH. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Art铆culo de los estatutos: 2. Objeto social.-. Cambio de domiciliosocial. AVDA TECNICA 5 - POLIGONO INDUSTRIAL SANTA ANA (RIVAS-VACIAMADRID). Cambio de objeto social. la compra,venta, importaci贸n y exportaci贸n de material industrial de aplicaci贸n general en la industria, especialmente bombas y equipos moto-bombas para trasiego y transporte de toda clase de fluidos, as铆 como la fabricaci贸n, reparaci贸n, mantenimiento y arrendamiento debombas, sus partes, piezas. Datos registrales. T 28912 , F 136, S 8, H M 116866, I/A 81 (28.09.16).

10 de Diciembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: OLMO FERNANDEZ MANUEL. Datos registrales. T 28912 , F 136, S 8, H M 116866, I/A 80 (1.12.15).

17 de Enero de 2014
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 28912 , F 135, S 8, H M 116866, I/A 79 ( 9.01.14).

24 de Junio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: STREICHER MICHAEL;TRITSCHLER MARKUS;FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Con.Delegado:STREICHER MICHAEL. Presidente: STREICHER MICHAEL. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Nombramientos.Consejero: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO;HIRVENSALO MIKKO;COMAR ALESSANDRO. Presidente: HIRVENSALO MIKKO.Con.Delegado: HIRVENSALO MIKKO. Secretario: FRUHBECK OLMEDO GUILLERMO. Datos registrales. T 28912 , F 135, S 8, H M116866, I/A 78 (17.06.13).

19 de Abril de 2013
Revocaciones. Apoderado: DIAZ PEREZ ALFONSO. Apo.Man.Soli: FUSTER FUSTER JOSE ANTONIO;LOPEZ GAGO JESUS.Apoderado: DURANGO ALCALDE ANGEL;SANTISO VAZQUEZ ROBERT;GIJON MARTINEZ ALFREDO;GALLARDO PIEDRARAFAEL;ENRIQUEZ MIGUEL JUAN CARLOS;LOPEZ RODRIGUEZ LEOPOLDO;RUIZ FLORES JAVIER;MARIN POVEDA JOSEIGNACIO;ALVAREZ GONZALEZ CARLOS-ALBERTO;QUINTELA SANTANA IVAN-JORGE;JUAN CALDERON NOEL;LOPEZ GAGOJESUS;FUSTER FUSTER JOSE ANTONIO;REY GONZALEZ PABLO. Apo.Sol.: ALVAREZ GONZALEZ CARLOS-ALBERTO;REYGONZALEZ PABLO;FUSTER FUSTER JOSE ANTONIO;LOPEZ GAGO JESUS. Apo.Manc.: MULLER GERT;RUCKSTUHL HOLGER.Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ GAGO JESUS;PEY LOPEZ JORGE;MARTIN ESPINOSA EVA. Apo.Sol.: DURANGOALCALDE ANGEL;RUIZ FLORES JAVIER;ALVAREZ GONZALEZ CARLOS-ALBERTO;QUINTELA SANTANA IVAN-JORGE;GARCIAALVAREZ PABLO;BART JANSSEN;BASSA CARLOS;DIAZ PEREZ ALFONSO. Otros conceptos: REVOCADOS LOS PODERESCONFERIDOS A FAVOR DE DON JUAN PEREZ SEGURA Y DO脩A MARINA HEINZE MEDIANTE ESCRITURA OTORGADA EL DIA27 DE OCTUBRE DE 1993 ANTE EL NOTADIO DE MADRID, DON FEDERICO PAREDERO DEL BOSQUE MARTIN, BAJO ELNUMERO 2979 DE SU PROTOCOLO Y QUE CAUSO LA INSCRIPCION 22& DE LA HOJA SOCIAL. Datos registrales. T 28912 , F132, S 8, H M 116866, I/A 77 (11.04.13).

28 de Enero de 2013
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28912 , F 132, S 8, H M 116866, I/A 76 (16.01.13).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n