Actos BORME de Sumba Pv Iii Sl
30 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 33972 , F 96, S 8, H M 611356, I/A 13 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 33972 , F 95, S 8, H M 611356, I/A 12 (15.12.22).
14 de Mayo de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SONNEDIX OMICRON SL. Datos registrales. T 33972 , F 95, S 8, HM 611356, I/A 11 ( 7.05.21).
26 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL;GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE. Datosregistrales. T 33972 , F 94, S 8, H M 611356, I/A 10 (19.04.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID). Datosregistrales. T 33972 , F 94, S 8, H M 611356, I/A 9 (25.03.21).
26 de Junio de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V 178605, I/A 7(18.06.20).
Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS;VILLALBA CORTES JUAN PABLO;VILLALBA CORTES JUAN PABLO.Datos registrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V 178605, I/A 8 (18.06.20).
Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V 178605, I/A 9(18.06.20).
13 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAARN-LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NORMANN MARC. Datosregistrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V 178605, I/A 6 ( 6.05.20).
05 de Noviembre de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMAN. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V 178605, I/A 4(26.10.18).
Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;WILLY KARTES TILLMANN KLAUS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 62, S 8, H V178605, I/A 5 (26.10.18).
07 de Septiembre de 2018Revocaciones. Apoderado: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 61, S 8, H V 178605, I/A 3 (31.08.18).
17 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFICINA 305 (ALFAFAR). Datos registrales. T 10382, L 7663, F61, S 8, H V 178605, I/A 2 ( 8.11.17).
24 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 33972 , F 79, S 8, H M 611356, I/A 7 (15.03.17).
01 de Febrero de 2017Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GREEN POWER PARTNERS K/S. Datos registrales. T 33972 , F79, S 8, H M 611356, I/A 6 (25.01.17).
12 de Enero de 2017Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 33972 , F 78, S 8, H M 611356, I/A 5 (3.01.17).
19 de Diciembre de 2016Nombramientos. Apoderado: VILLALBA CORTES JUAN PABLO;VILLALBA CORTES JUAN PABLO;WICKE RICHARD;GANDIAFORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 33972 , F 78, S 8, H M 611356, I/A 4 ( 9.12.16).
05 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN-LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GAARN-LARSEN LARS CHRISTIAN. Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 8潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico. Datos registrales. T33972 , F 77, S 8, H M 611356, I/A 3 (24.11.16).
12 de Noviembre de 2015Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 5. Domicilio.-. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA HABANA 5 - 1潞.-DERECHA (MADRID). Datos registrales. T 33972 , F 77, S 8, H M 611356, I/A 2 ( 4.11.15).
15 de Julio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1186 , F 56,S 8, H L 23620, I/A 9 ( 3.07.15).
Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Datos registrales. T 1186 , F 56, S 8, H L 23620,I/A 10 ( 7.07.15).
01 de Agosto de 2014Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 1186 , F 54, S 8, H L 23620, I/A 7(21.07.14).
Nombramientos. Apoderado: NEXUS ENERGIA SA;NEXUS ENERGIA SA. Datos registrales. T 1186 , F 55, S 8, H L 23620, I/A 8(21.07.14).
11 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: SEEM ERIC KRISTOFFER. Nombramientos. Adm. Solid.: GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN.Datos registrales. T 1186 , F 54, S 8, H L 23620, I/A 6 ( 3.04.13).
17 de Julio de 2012Otros conceptos: Subsanan la inscripci贸n 2& del historial de la sociedad, enrelaci贸n con el N.I.E. del Administrador Solidario, donChristian Liebel, que es el Y0826700-W y no el Y0286700-W, comoas铆 se hizo constar por error en dicha inscripci贸n 2&. Datosregistrales. T 1186 , F 54, S 8, H L 23620, I/A 5 ( 6.07.12).
11 de Julio de 2011Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SOLAR ROOFTOP SPANIEN I BETEILIGUNGS GMBH. Datosregistrales. T 1186 , F 54, S 8, H L 23620, I/A 4 (29.06.11).
20 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: PELLICER AMBERT JORDI;PINOS CRESPO FRANCESC. Nombramientos. Adm. Solid.: SEEMERIC KRISTOFFER;LIEBEL CHRISTIAN. Datos registrales. T 1186 , F 53, S 8, H L 23620, I/A 2 ( 7.04.10).
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: GREEN POWERS PARTNERS K/S. Datos registrales. T 1186 , F53, S 8, H L 23620, I/A 3 ( 7.04.10).
29 de Abril de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 3.03.09. Objeto social: - Compraventa y explotaci贸n de plantas solares fotovoltaicas. -