Actos BORME de Sumelpa Sal
27 de Diciembre de 2021Extinci贸n. Datos registrales. T 472 , F 201, S 8, H P 2219, I/A 22 (17.12.21).
31 de Enero de 2018Ceses/Dimisiones. Secretario: SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL. Nombramientos. Secretario: REBOLLEDO MEDIAVILLA ANAMARIA. Con.Delegado: REBOLLEDO MEDIAVILLA ANA MARIA. Consejero: PETIZCO RUIZ JOSE ANGEL. Adaptaci贸n Ley44/2015. Modificaciones estatutarias. 6. Capital social.-El capital social se fija en SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTAEUROS (76.930,00 Euros), representado por DOSCIENTAS acciones nominativas, de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROSCON SESENTA Y CINCO CENTIMOS (384,65 Euros) de valor nominal cada una de ellas, numeradas. Datos registrales. T 472 , F199, S 8, H P 2219, I/A 20 (18.01.18).
26 de Septiembre de 2017P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.sumelpa.es. Datos registrales. T 472 , F 199, S 8, H P2219, I/A nota (19.09.17).
16 de Marzo de 2017Revocaciones. Auditor: SILCHRIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 472 , F 199, S 8, H P 2219, I/A 19 ( 9.03.17).
01 de Septiembre de 2015Reelecciones. Consejero: RAMOS MARTIN INOCENCIO;SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL;REBOLLEDO MEDIAVILLA ANAMARIA. Presidente: RAMOS MARTIN INOCENCIO. Cons.Del.Sol: SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL;RAMOS MARTININOCENCIO. Secretario: SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL. Datos registrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 18 (20.08.15).
30 de Enero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: ANTOLIN SANTOS PEDRO. Nombramientos. Consejero: REBOLLEDO MEDIAVILLA ANA MARIA.Datos registrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 16 (22.01.15).
Nombramientos. Auditor: SILCHRIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 17 (22.01.15).
29 de Mayo de 2014Nombramientos. Auditor: SILCHRIS AUDITORES SL. Datos registrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 15 (22.05.14).
07 de Marzo de 2013Nombramientos. Consejero: ANTOLIN SANTOS PEDRO. Modificaciones estatutarias. 18. Funcionamiento Junta Gral.-. Datosregistrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 14 (28.02.13).
13 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: SAMUEL MARCILLA RUIZ. Datos registrales. T 220 , F 136, S 8, H P 2219, I/A 13 ( 3.07.12).
28 de Octubre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: MARTIN ANDRES SEVERINO. Nombramientos. Consejero: SAMUEL MARCILLA RUIZ.Reelecciones. Consejero: RAMOS MARTIN INOCENCIO;SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL. Presidente: RAMOS MARTININOCENCIO. Secretario: SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL. Cons.Del.Sol: SANTOS FERNANDEZ LUIS ANGEL;RAMOS MARTININOCENCIO. Datos registrales. T 220 , F 135, S 8, H P 2219, I/A 12 (18.10.10).
06 de Septiembre de 2010Nombramientos. Apoderado: REBOLLEDO MEDIAVILLA ANA MARIA. Datos registrales. T 220 , F 135, S 8, H P 2219, I/A 11(13.08.10).