Buscador CIF Logo

Actos BORME Suministro De Luz Y Fuerza Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Suministro De Luz Y Fuerza Sl

Actos BORME Suministro De Luz Y Fuerza Sl - B17612185

Tenemos registrados 20 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Suministro De Luz Y Fuerza Sl con CIF B17612185

🔙 Perfil de Suministro De Luz Y Fuerza Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Suministro De Luz Y Fuerza Sl

27 de Octubre de 2023
Revocaciones. APOD.SOL/MAN: VIZCAINO RECIO FRANCISCO;PRADO VILLANUEVA MIGUEL;PALOMARES FERNANDEZANTONIO;SANCHEZ LOPEZ VICTOR. APODERAD.SOL: NUÑEZ SANCHEZ ARJONA ANGEL. APOD.SOL/MAN: LUCAPASSA;BLASCO BLASCO EMILIO. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: MERINO CIUDAD MARIA JESUS;PEIRO MESAJORGE;MELERO LOPEZ ELISA;ALVAREZ BARRO MARIA;GONZALEZ NAVARRO CARMEN;MARCO PALERMO. Datosregistrales. T 46428 , F 160, S 8, H B 519677, I/A 48 (19.10.23).

19 de Julio de 2023
Nombramientos. AUDIT.INDIV.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 46428 , F 159, S 8, H B 519677, I/A 47 (10.07.23).

16 de Mayo de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JUAN MANUEL JIMENEZ NAVARRO. Apo.Manc.: JOAN PALOMERAS ADMETLLER.Nombramientos. Apo.Man.Soli: LUIS MONTAÑES BELLOSTA. Datos registrales. T 2980 , F 215, S 8, H GI 24809, I/A 35 (7.05.18).

21 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ADOLFO GARCIA NOMBELA;MARIA EMMA ROBLES GARCIA;GONZALO GARCIACATTANEO;GUILLERMO ALVAREZ OREJAS;GUILLERMO PRADO VILLANUEVA;IVAN LOPEZ FERNANDEZ;ANTONIO MARIORODRIGUEZ VIDAL. Apo.Manc.: ELENA MARTIN GIL;CARLOS AREVALO BARJOLA. Datos registrales. T 2980 , F 135, S 8, H GI24809, I/A 34 (14.02.18).

05 de Enero de 2018
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Consejero: FRANCISCO JAVIER CASTELLET GRAU. Secretario: FRANCISCOJAVIER CASTELLET GRAU. Datos registrales. T 2980 , F 135, S 8, H GI 24809, I/A 33 (28.12.17).

29 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ANTONIO ALBARRAN RUIZ;ANTONIO RIQUELME BROTONS;FRANCISCO JAVIER LOPEZ DEVILLALTA PEINADO. Datos registrales. T 2980 , F 132, S 8, H GI 24809, I/A 32 (21.11.16).

02 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: AGUSTI LLORENS SERRATS. Apo.Man.Soli: JOSE ANTONIO CASTAN CASTAN;JAIME RAMIREZFLO. Apo.Manc.: JOSE ANTONIO CASTAN CASTAN. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIO JAVIER RAMON TEIJELO;FRANCISCOVIZCAINO RECIO;ANTONIO ALBARRAN RUIZ. Apo.Sol.: JOAQUIN DORADO DORADO. Datos registrales. T 2980 , F 132, S 8, HGI 24809, I/A 31 (24.10.16).

22 de Agosto de 2016
Cambio de objeto social. La Sociedad tiene por objeto el desarrollo de actividades de transporte y distribución de energía eléctrica.La Sociedad desarrollará las actividades que comprenden su objeto social bien directamente, bien indirectamente mediante laparticipación de otras sociedades mercantiles. Datos registrales. T 2980 , F 132, S 8, H GI 24809, I/A 30 (11.08.16).

22 de Abril de 2016
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS LALUEZA LANAU. Apo.Manc.: JOAN PALOMERAS ADMETLLER. Datos registrales. T2980 , F 131, S 8, H GI 24809, I/A 29 (14.04.16).

13 de Agosto de 2015
Reelecciones. Consejero: MARIA CLARA PLA MONTANER;FRANCISCO VIZCAINO RECIO. Presidente: FRANCISCO VIZCAINORECIO. Datos registrales. T 2980 , F 130, S 8, H GI 24809, I/A 27 ( 5.08.15).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: JUAN MANUEL JIMENEZ NAVARRO. Datos registrales. T 2980 , F 130, S 8, H GI 24809, I/A 28 (5.08.15).

20 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2980 , F 130, S 8, H GI 24809, I/A 26 (13.10.14).

15 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSEP GRAU GUINART. Apo.Manc.: JOSEP GRAU GUINART. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PIOJAVIER RAMON TEIJELO. Datos registrales. T 2311 , F 101, S 8, H GI 24809, I/A 25 ( 8.10.14).

11 de Agosto de 2014
Revocaciones. Apoderado: ALBERTO ESTRUCH BELLES;MIGUEL ESPINAR AGUSTIN. Apo.Man.Soli: JORDI VILA OLIVAN;JUANMARIA JUBANY CASANOVAS;ANTONIO CASTAN CASTAN;PERE CANUT HEREU. Nombramientos. Apo.Manc.: JOSEP GRAUGUINART;JOSE ANTONIO CASTAN CASTAN. Datos registrales. T 2311 , F 101, S 8, H GI 24809, I/A 24 (31.07.14).

26 de Junio de 2013
Revocaciones. Apoderado: FRANCESC MEJIAS MONT. Nombramientos. Apo.Man.Soli: OSCAR REDONDO LOPEZ. Datosregistrales. T 2311 , F 100, S 8, H GI 24809, I/A 23 (19.06.13).

24 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 2311 ,F 99, S 8, H GI 24809, I/A 21 (13.01.12).

28 de Septiembre de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOSEP NOGUER AROLA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: JOSEP GRAU GUINART. Datosregistrales. T 2311 , F 98, S 8, H GI 24809, I/A 20 (19.09.11).

25 de Enero de 2011
Ceses/Dimisiones. Consejero: AGUSTI MANEL LOPEZ RODRIGUEZ. Revocaciones. Apo.Man.Soli: JOAQUIM RABIONETSERRAT. Nombramientos. Apoderado: FRANCESC MEJIAS MONT. Presidente: FRANCISCO VIZCAINO RECIO. Datosregistrales. T 2311 , F 97, S 8, H GI 24809, I/A 19 (13.01.11).

18 de Junio de 2010
Reelecciones. Auditor: RCM AUDITORES SL. Datos registrales. T 2311 , F 96, S 8, H GI 24809, I/A 17 ( 8.06.10).

Ceses/Dimisiones. Auditor: RCM AUDITORES SL. Cons.Del.Man: MARIA CLARA PLA MONTANER. Nombramientos. Auditor:KPMG AUDITORES SL. Reelecciones. Consejero: MARIA CLARA PLA MONTANER;ALBERTO ESTRUCH BELLES. Secretario:ALBERTO ESTRUCH BELLES. Datos registrales. T 2311 , F 97, S 8, H GI 24809, I/A 18 ( 9.06.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información