Actos BORME de Suministros De Comercio Exterior Sa
24 de Mayo de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: BENATAR LEITMAN RAPHAEL;QUERUB PERELIS DANIEL. Nombramientos. Adm. Unico:EUROFINSA SA. Representan: TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO. Modificaciones estatutarias. Refundici贸n de losestatutos sociales.. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador 煤nico.Datos registrales. T 28846 , F 73, S 8, H M 147993, I/A 66 (17.05.21).
14 de Septiembre de 2020Cambio de domicilio social. C/ VELAZQUEZ 157 (MADRID). Datos registrales. T 28846 , F 73, S 8, H M 147993, I/A 65 ( 7.09.20).
06 de Mayo de 2020Ceses/Dimisiones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28846 , F 73, S 8, H M 147993, I/A 64 (28.04.20).
22 de Enero de 2019Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 28846 , F 72, S 8, H M 147993, I/A 63 (15.01.19).
19 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28846 , F 72, S 8, H M 147993, I/A 62 ( 7.04.17).
14 de Diciembre de 2016Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.371.564,00 Euros. Resultante Suscrito: 251.478,66 Euros. Datos registrales. T 28846 ,F 71, S 8, H M 147993, I/A 61 ( 5.12.16).
26 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: TOLEDANO QUERUB DANIEL;BREA GONZALEZ JOSE RAMON. Apoderado: TOLEDANO MARQUESMAURICIO;RUIZ RUBIO GERARDO. Datos registrales. T 28846 , F 71, S 8, H M 147993, I/A 60 (18.05.16).
22 de Abril de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: EUROFINSA SA;IBT GROUP LLC. Representan: TOLEDANO MARQUES MOISESMAURICIO;BREA GONZALEZ JOSE RAMON. Datos registrales. T 28846 , F 71, S 8, H M 147993, I/A 58 (14.04.16).
Nombramientos. Adm. Solid.: BENATAR LEITMAN RAPHAEL;QUERUB PERELIS DANIEL. Datos registrales. T 28846 , F 71, S 8,H M 147993, I/A 59 (14.04.16).
20 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 57.415,65 Euros. Resultante Suscrito: 1.623.042,66 Euros. Datos registrales. T 28846 , F70, S 8, H M 147993, I/A 57 (10.04.15).
07 de Abril de 2015Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 173.138,12 Euros. Resultante Suscrito: 1.680.458,31 Euros. Datos registrales. T 28846 ,F 69, S 8, H M 147993, I/A 56 (26.03.15).
16 de Febrero de 2015Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: IBT GROUP LLC. Datos registrales. T 28846 , F 69, S 8, H M 147993, I/A 54 (9.02.15).
P谩gina web de la sociedad. Creaci贸n de la p谩gina web corporativa: www.sucomex.com. Datos registrales. T 28846 , F 69, S 8, HM 147993, I/A 55 ( 9.02.15).
22 de Octubre de 2014Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO JAVIER ABAD HERNANDO. Datos registrales. T 28846 , F 67, S 8, H M 147993, I/A 50(13.10.14).
Nombramientos. Apoderado: VEGA INTRIAGO MARIA JOSE. Datos registrales. T 28846 , F 68, S 8, H M 147993, I/A 51(13.10.14).
Revocaciones. Apoderado: MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO. Datos registrales. T 28846 , F 68, S 8, H M 147993, I/A 52(13.10.14).
Nombramientos. Apoderado: ROMPINELLI SAEZ ANA BELEN. Datos registrales. T 28846 , F 68, S 8, H M 147993, I/A 53(13.10.14).
17 de Junio de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO;TOLEDANO QUERUB DANIEL;BREA GONZALEZ JOSERAMON. Presidente: BREA GONZALEZ JOSE RAMON. Consejero: TOLEDANO MARQUES MAURICIO;RUIZ RUBIO GERARDO.Vicepresid.: RUIZ RUBIO GERARDO. SecreNoConsj: LANCHARES PERLADO MARIA JOSE. Nombramientos. Adm. Solid.: IBTGROUP LLC;EUROFINSA SA. Representan: TOLEDANO MARQUES MOISES MAURICIO;BREA GONZALEZ JOSE RAMON.Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores solidarios. Semodifican y refunden la totalidad de los Estatutos Sociales.. Datos registrales. T 28846 , F 64, S 8, H M 147993, I/A 49 ( 9.06.14).
08 de Octubre de 2013Nombramientos. Apoderado: MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO. Datos registrales. T 28846 , F 64, S 8, H M 147993, I/A 48(30.09.13).
21 de Diciembre de 2012Ampliacion del objeto social. EXPORTACION E IMPORTACION O VENTAS NACIONALES SI PROCEDE, DE TODO TIPO DEEQUIPOS Y PRODUCTOS. LA PRESTACION DE SERVICIOS CONEXOS CON LAS ACTIVIDADESDE EXPORTACION EIMPORTACION, INCLUYENDO LA CONSULTORIA, MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS, SERVICIOS DE PUESTA ENMARCHA Y OPERACION, FORMACION DE USU. Datos registrales. T 28846 , F 63, S 8, H M 147993, I/A 47 (13.12.12).
20 de Noviembre de 2012Revocaciones. Apoderado: ENTRENA GUTIERREZ MARIA JOSE. Apo.Sol.: RUIZ RUBIO VICTOR. Nombramientos. Apoderado:TOLEDANO MARQUES MAURICIO. Datos registrales. T 28846 , F 62, S 8, H M 147993, I/A 45 ( 6.11.12).
Revocaciones. Apo.Sol.: RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL. Nombramientos. Vicepresid.: RUIZ RUBIO GERARDO. Apoderado: RUIZRUBIO GERARDO. Datos registrales. T 28846 , F 62, S 8, H M 147993, I/A 46 ( 6.11.12).
16 de Noviembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL. Vicepresid.: RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL. Nombramientos.Consejero: RUIZ RUBIO GERARDO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 175.175,05 Euros. Resultante Suscrito: 1.853.596,43Euros. Datos registrales. T 28846 , F 60, S 8, H M 147993, I/A 44 ( 6.11.12).
13 de Septiembre de 2012Nombramientos. Consejero: TOLEDANO MARQUES MAURICIO. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 28846 , F 60,S 8, H M 147993, I/A 43 (21.08.12).
17 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: RUIZ RUBIO VICTOR. Datos registrales. T 28846 , F 60, S 8, H M 147993, I/A 42 ( 3.07.12).
20 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: VAZQUEZ VEGA Y CASANOVA JOSE ANTONIO. Nombramientos. SecreNoConsj:LANCHARES PERLADO MARIA JOSE. L. Asesor: LANCHARES PERLADO MARIA JOSE. Datos registrales. T 28846 , F 59, S 8, HM 147993, I/A 41 ( 7.07.11).
16 de Junio de 2011Nombramientos. Apo.Sol.: TOLEDANO QUERUB DANIEL;BREA GONZALEZ JOSE RAMON;RUIZ RUBIO VICTOR. Datosregistrales. T 28846 , F 58, S 8, H M 147993, I/A 39 ( 6.06.11).
Ceses/Dimisiones. Presidente: RUIZ RUBIO VICTOR. Nombramientos. Presidente: BREA GONZALEZ JOSE RAMON. Datosregistrales. T 28846 , F 59, S 8, H M 147993, I/A 40 ( 6.06.11).
14 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NAVARRO VALENZUELA ROSARIO. Presidente: MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO.Nombramientos. Consejero: TOLEDANO QUERUB DANIEL;BREA GONZALEZ JOSE RAMON;RUIZ RUBIO VICTOR. Presidente:RUIZ RUBIO VICTOR. Reelecciones. Consejero: RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO. Vicepresid.:RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL. Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 28.771,48 Euros. Desembolsado: 28.771,48 Euros. ResultanteSuscrito: 2.028.771,48 Euros. Resultante Desembolsado: 2.028.771,48 Euros. Modificaciones estatutarias. Modificados los
14 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: NOLSCHER WOLFGANG;HALLBAUER PETER;RAFFASEDER ANDREA. Presidente: RAFFASEDERANDREA. Revocaciones. Apo.Sol.: KALTEMBOECK CHRISTIAN;NOELSCHER WOLFGANG. Apoderado: DE SAS PRADAALFONSO LUIS. Nombramientos. Consejero: NAVARRO VALENZUELA ROSARIO. Presidente: MARQUEZ GONZALEZLEONARDO. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 16潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.. Datosregistrales. T 19421 , F 16, S 8, H M 147993, I/A 37 ( 5.04.11).
03 de Agosto de 2010Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 125.205,88 Euros. Resultante Suscrito: 1.524.794,12 Euros. Ampliaci贸n de capital.Suscrito: 475.205,88 Euros. Desembolsado: 475.205,88 Euros. Resultante Suscrito: 2.000.000,00 Euros. Resultante Desembolsado:2.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 19421 , F 15, S 8, H M 147993, I/A 36 (23.07.10).
30 de Junio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: MANZANO ARENAS RAFAEL ALBERTO. Nombramientos. SecreNoConsj: VAZQUEZ VEGA YCASANOVA JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 19421 , F 15, S 8, H M 147993, I/A 35 (18.06.10).
12 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: DE SAS PRADA ALFONSO LUIS. Datos registrales. T 19421 , F 14, S 8, H M 147993, I/A 34 (3.08.09).
05 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: STRAHLHOFER JOHANN. Presidente: NOLSCHER WOLFGANG. Nombramientos. Consejero:RAFFASEDER ANDREA. Presidente: RAFFASEDER ANDREA. Reelecciones. Consejero: NOLSCHER WOLFGANG;HALLBAUERPETER;RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL;MARQUEZ GONZALEZ LEONARDO. Vicepresid.: RUIZ-VILLAR RUIZ RAFAEL. Datosregistrales. T 19421 , F 14, S 8, H M 147993, I/A 32 (21.04.09).
Reelecciones. Auditor: AUDALIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 19421 , F 14, S 8, H M 147993, I/A 33 (21.04.09).