Buscador CIF Logo

Actos BORME Suministros Electricos Erka Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Suministros Electricos Erka Sl

Actos BORME Suministros Electricos Erka Sl - B20042842

Tenemos registrados 31 Actos BORME del Registro Mercantil de Guipuzcoa para Suministros Electricos Erka Sl con CIF B20042842

馃敊 Perfil de Suministros Electricos Erka Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Guipuzcoa

Actos BORME de Suministros Electricos Erka Sl

16 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 57 (22.10.20).

Otros conceptos: REVOCACION como AUDITOR DE LAS CUENTAS ANUALES DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 a "KPMGAUDITORES, S.L.".- Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 58 (22.10.20).

Nombramientos. Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 59(22.10.20).

20 de Marzo de 2020
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ERKA SOLUCIONES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.:MARCOS ORTEGA JOSE LUIS;SCHOETTEL MARC-ERIK. Nombramientos. Adm. Unico: VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO.Rep.SUC.: VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO. Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 16潞 de los Estatutos Sociales, relativoa la composicion del Organo de Administraci贸n. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 2765 , F 220, S 8, H SS 1209, I/A 55 ( 5.03.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SOSKIC JOSE CARLOS;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO. Apo.Sol.: MARCOS ORTEGAJOSE LUIS;SCHOETTEL MARC-ERIK;BERAZALUCE MINONDO ANGELES. Apo.Manc.: ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datosregistrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 56 (11.03.20).

24 de Octubre de 2019
Revocaciones. Apoderado: USERO FERNANDEZ JAVIER. Apo.Manc.: SCHOETTEL MARC-ERIK;VILLANUEVA RODRIGUEZANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;USERO FERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: SCHOETTEL MARC-ERIK;MARCOS ORTEGA JOSE LUIS;BERAZALUCE MINONDO ANGELES. Apo.Manc.: GARCIA SOSKIC JOSECARLOS;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datos registrales. T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209,I/A 54 (16.10.19).

15 de Octubre de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SCHOETTEL MARC-ERIK. Nombramientos. Adm. Solid.: SCHOETTEL MARC-ERIK;MARCOSORTEGA JOSE LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios.Datos registrales. T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209, I/A 52 ( 3.10.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: FREIRE ROMERO IGNACIO;VEGAS VICENTE LUIS;FLORES LLAVE SARA. Datos registrales. T 2765, F 219, S 8, H SS 1209, I/A 53 ( 3.10.19).

20 de Marzo de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;CASTA脩ON ORUE I脩AKI;USERO FERNANDEZ JAVIER;VILLANUEVARODRIGUEZ ANTONIO. Apo.Sol.: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: SCHOETTELMARC-ERIK;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;USERO FERNANDEZ JAVIER. Datosregistrales. T 2765 , F 218, S 8, H SS 1209, I/A 51 (13.03.19).

13 de Febrero de 2019
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Representan: BAIXINHO DE CARVALHO HELDERCARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SCHOETTEL MARC-ERIK. Representan: SCHOETTEL MARC-ERIK. Datos registrales. T2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 50 (30.01.19).

27 de Octubre de 2017
Cambio de domicilio social. POLIG IND. TXIRRITA MALEO, 4 (ERRENTERIA). Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209,I/A 49 ( 9.10.17).

24 de Febrero de 2017
Ceses/Dimisiones. Consejero: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;USERO FERNANDEZ JAVIER;TARRIDA LLOPARTJORGE.Secretario: USERO FERNANDEZ JAVIER. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos. Adm. Unico:BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 47 (14.02.17).

Ceses/Dimisiones. Representan: TARRIDA LLOPART JORGE. Revocaciones. Apo.Manc.: ERREJON SAINZ DE LA MAZAGONZALO. Apo.Man.Soli: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO. Apo.Manc.: BOUCTOT YANN FREDERIC;ORTIZ CALDERONRAUL JUAN;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;BURON CORRAL VICTORMANUEL;MARTIN MARTINEZ JOSE;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;SAENZ OLIVEROS UNAX. Apo.Man.Soli: BOUCTOTYANN FREDERIC;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;CARPINTERO ATIENZATOMAS;TUDURI LABOA ANDER. Apo.Sol.: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos. Apoderado: USERO FERNANDEZJAVIER. Representan: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 48(15.02.17).

18 de Noviembre de 2016
Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1281 , F 105, S 8, H SS 1209, I/A 46 ( 9.11.16).

17 de Mayo de 2016
Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1281 , F 105, S 8, H SS 1209, I/A 45 ( 4.05.16).

23 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZATOMAS. SecreNoConsj: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos.Consejero: TARRIDA LLOPART JORGE;USERO FERNANDEZ JAVIER;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS.Presidente:TARRIDA LLOPART JORGE. Secretario: USERO FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 1281 , F 104, S 8, H SS 1209, I/A 43 (9.02.16).

Revocaciones. Apo.Manc.: BURON CORRAL VICTOR MANUEL;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;TARRIDA LLOPARTJORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DECARVALHO HELDER CARLOS. Apo.Manc.: USERO FERNANDEZ JAVIER;CASTA脩ON ORUE I脩AKI;VILLANUEVA RODRIGUEZANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datos registrales. T 1281 , F 104, S 8, H SS 1209, I/A 44 ( 9.02.16).

30 de Septiembre de 2015
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Nombramientos. Consejero: TARRIDA LLOPARTJORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE.SecreNoConsj: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 41 (17.09.15).

Nombramientos. Apo.Manc.: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZATOMAS;BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 42 (17.09.15).

04 de Abril de 2013
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 40 (25.03.13).

23 de Octubre de 2012
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ABM REXEL SL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 39(11.10.12).

25 de Junio de 2012
Nombramientos. Apo.Manc.: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO;BOUCTOT YANN FREDERIC;ORTIZ CALDERON RAULJUAN;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;BURON CORRAL VICTOR MANUEL;MARTINMARTINEZ JOSE;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;SAENZ OLIVEROS UNAX. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS1209, I/A 35 (14.06.12).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO;BOUCTOT YANN FREDERIC;ALVAREZ HERNANDEZJOSE MANUEL;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;TUDURI LABOA ANDER Datosregistrales. T 1281 , F 101, S 8, H SS 1209, I/A 36 (14.06.12).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 102, S 8, H SS 1209, I/A 37(15.06.12).

Nombramientos. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 102, S 8, H SS 1209, I/A 38(15.06.12).

16 de Marzo de 2012
Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: OTA脩O IBARROLA HILARIO. Nombramientos. Aud.Supl.: HERNANDO LOPEZ OSCAR LUIS.Reelecciones. Auditor: CRUZ BIENZOBAS FELIPE. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 34 ( 7.03.12).

20 de Febrero de 2012
Revocaciones. Apo.Sol.: CARPINTERO ATIENZA TOMAS;ERAUSQUIN IZTUETA FELIPE. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8,H SS 1209, I/A 33 ( 7.02.12).

22 de Diciembre de 2011
Revocaciones. Apo.Sol.: CARPINTERO ATIENZA TOMAS;ERAUSQUIN IZTUETA FELIPE;CARPINTERO ATIENZATOMAS;CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 32 (13.12.11).

29 de Abril de 2011
Ceses/Dimisiones. Apoderado: SANCHEZ ANDRES LUIS. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 31 (18.04.11).

18 de Noviembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 43.395,74 Euros. Resultante Suscrito: 50.085,00 Euros. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, HSS 1209, I/A 30 ( 9.11.10).

24 de Marzo de 2009
Reelecciones. Auditor: CRUZ BIENZOBAS FELIPE. Aud.Supl.: OTA脩O IBARROLA HILARIO. Datos registrales. T 1281 , F 100, S8, H SS 1209, I/A 29 (12.03.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n