Actos BORME de Suministros Electricos Erka Sl
16 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 57 (22.10.20).
Otros conceptos: REVOCACION como AUDITOR DE LAS CUENTAS ANUALES DE LOS EJERCICIOS 2020 Y 2021 a "KPMGAUDITORES, S.L.".- Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 58 (22.10.20).
Nombramientos. Auditor: EASO AUDITORES CONSULTORES SL. Datos registrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 59(22.10.20).
20 de Marzo de 2020Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: ERKA SOLUCIONES SL. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.:MARCOS ORTEGA JOSE LUIS;SCHOETTEL MARC-ERIK. Nombramientos. Adm. Unico: VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO.Rep.SUC.: VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO. Otros conceptos: Modificaci贸n del Art铆culo 16潞 de los Estatutos Sociales, relativoa la composicion del Organo de Administraci贸n. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 2765 , F 220, S 8, H SS 1209, I/A 55 ( 5.03.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: GARCIA SOSKIC JOSE CARLOS;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO. Apo.Sol.: MARCOS ORTEGAJOSE LUIS;SCHOETTEL MARC-ERIK;BERAZALUCE MINONDO ANGELES. Apo.Manc.: ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datosregistrales. T 2765 , F 221, S 8, H SS 1209, I/A 56 (11.03.20).
24 de Octubre de 2019Revocaciones. Apoderado: USERO FERNANDEZ JAVIER. Apo.Manc.: SCHOETTEL MARC-ERIK;VILLANUEVA RODRIGUEZANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;USERO FERNANDEZ JAVIER. Nombramientos. Apo.Sol.: SCHOETTEL MARC-ERIK;MARCOS ORTEGA JOSE LUIS;BERAZALUCE MINONDO ANGELES. Apo.Manc.: GARCIA SOSKIC JOSECARLOS;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datos registrales. T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209,I/A 54 (16.10.19).
15 de Octubre de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SCHOETTEL MARC-ERIK. Nombramientos. Adm. Solid.: SCHOETTEL MARC-ERIK;MARCOSORTEGA JOSE LUIS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradores solidarios.Datos registrales. T 2765 , F 219, S 8, H SS 1209, I/A 52 ( 3.10.19).
Nombramientos. Apo.Sol.: FREIRE ROMERO IGNACIO;VEGAS VICENTE LUIS;FLORES LLAVE SARA. Datos registrales. T 2765, F 219, S 8, H SS 1209, I/A 53 ( 3.10.19).
20 de Marzo de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;CASTA脩ON ORUE I脩AKI;USERO FERNANDEZ JAVIER;VILLANUEVARODRIGUEZ ANTONIO. Apo.Sol.: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Nombramientos. Apo.Manc.: SCHOETTELMARC-ERIK;VILLANUEVA RODRIGUEZ ANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN;USERO FERNANDEZ JAVIER. Datosregistrales. T 2765 , F 218, S 8, H SS 1209, I/A 51 (13.03.19).
13 de Febrero de 2019Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Representan: BAIXINHO DE CARVALHO HELDERCARLOS. Nombramientos. Adm. Unico: SCHOETTEL MARC-ERIK. Representan: SCHOETTEL MARC-ERIK. Datos registrales. T2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 50 (30.01.19).
27 de Octubre de 2017Cambio de domicilio social. POLIG IND. TXIRRITA MALEO, 4 (ERRENTERIA). Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209,I/A 49 ( 9.10.17).
24 de Febrero de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;USERO FERNANDEZ JAVIER;TARRIDA LLOPARTJORGE.Secretario: USERO FERNANDEZ JAVIER. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos. Adm. Unico:BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸na Administrador 煤nico. Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 47 (14.02.17).
Ceses/Dimisiones. Representan: TARRIDA LLOPART JORGE. Revocaciones. Apo.Manc.: ERREJON SAINZ DE LA MAZAGONZALO. Apo.Man.Soli: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO. Apo.Manc.: BOUCTOT YANN FREDERIC;ORTIZ CALDERONRAUL JUAN;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;BURON CORRAL VICTORMANUEL;MARTIN MARTINEZ JOSE;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;SAENZ OLIVEROS UNAX. Apo.Man.Soli: BOUCTOTYANN FREDERIC;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;CARPINTERO ATIENZATOMAS;TUDURI LABOA ANDER. Apo.Sol.: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos. Apoderado: USERO FERNANDEZJAVIER. Representan: BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Datos registrales. T 2765 , F 217, S 8, H SS 1209, I/A 48(15.02.17).
18 de Noviembre de 2016Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1281 , F 105, S 8, H SS 1209, I/A 46 ( 9.11.16).
17 de Mayo de 2016Reelecciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1281 , F 105, S 8, H SS 1209, I/A 45 ( 4.05.16).
23 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZATOMAS. SecreNoConsj: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE. Nombramientos.Consejero: TARRIDA LLOPART JORGE;USERO FERNANDEZ JAVIER;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS.Presidente:TARRIDA LLOPART JORGE. Secretario: USERO FERNANDEZ JAVIER. Datos registrales. T 1281 , F 104, S 8, H SS 1209, I/A 43 (9.02.16).
Revocaciones. Apo.Manc.: BURON CORRAL VICTOR MANUEL;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;TARRIDA LLOPARTJORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS. Nombramientos. Apo.Sol.: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DECARVALHO HELDER CARLOS. Apo.Manc.: USERO FERNANDEZ JAVIER;CASTA脩ON ORUE I脩AKI;VILLANUEVA RODRIGUEZANTONIO;ESTEBAN ROBLEDO RUBEN. Datos registrales. T 1281 , F 104, S 8, H SS 1209, I/A 44 ( 9.02.16).
30 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Nombramientos. Consejero: TARRIDA LLOPARTJORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Presidente: TARRIDA LLOPART JORGE.SecreNoConsj: BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n:Administrador 煤nico a Consejo de administraci贸n. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 41 (17.09.15).
Nombramientos. Apo.Manc.: TARRIDA LLOPART JORGE;BAIXINHO DE CARVALHO HELDER CARLOS;CARPINTERO ATIENZATOMAS;BURON CORRAL VICTOR MANUEL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 42 (17.09.15).
04 de Abril de 2013Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 40 (25.03.13).
23 de Octubre de 2012Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ABM REXEL SL. Datos registrales. T 1281 , F 103, S 8, H SS 1209, I/A 39(11.10.12).
25 de Junio de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO;BOUCTOT YANN FREDERIC;ORTIZ CALDERON RAULJUAN;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;BURON CORRAL VICTOR MANUEL;MARTINMARTINEZ JOSE;ALVAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL;SAENZ OLIVEROS UNAX. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS1209, I/A 35 (14.06.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ERREJON SAINZ DE LA MAZA GONZALO;BOUCTOT YANN FREDERIC;ALVAREZ HERNANDEZJOSE MANUEL;CABALLERO ESCUDERO IGNACIO JOSE;CARPINTERO ATIENZA TOMAS;TUDURI LABOA ANDER Datosregistrales. T 1281 , F 101, S 8, H SS 1209, I/A 36 (14.06.12).
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 102, S 8, H SS 1209, I/A 37(15.06.12).
Nombramientos. Adm. Unico: CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 102, S 8, H SS 1209, I/A 38(15.06.12).
16 de Marzo de 2012Ceses/Dimisiones. Aud.Supl.: OTA脩O IBARROLA HILARIO. Nombramientos. Aud.Supl.: HERNANDO LOPEZ OSCAR LUIS.Reelecciones. Auditor: CRUZ BIENZOBAS FELIPE. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 34 ( 7.03.12).
20 de Febrero de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: CARPINTERO ATIENZA TOMAS;ERAUSQUIN IZTUETA FELIPE. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8,H SS 1209, I/A 33 ( 7.02.12).
22 de Diciembre de 2011Revocaciones. Apo.Sol.: CARPINTERO ATIENZA TOMAS;ERAUSQUIN IZTUETA FELIPE;CARPINTERO ATIENZATOMAS;CARPINTERO ATIENZA TOMAS. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 32 (13.12.11).
29 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Apoderado: SANCHEZ ANDRES LUIS. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, H SS 1209, I/A 31 (18.04.11).
18 de Noviembre de 2010Ampliaci贸n de capital. Capital: 43.395,74 Euros. Resultante Suscrito: 50.085,00 Euros. Datos registrales. T 1281 , F 100, S 8, HSS 1209, I/A 30 ( 9.11.10).
24 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: CRUZ BIENZOBAS FELIPE. Aud.Supl.: OTA脩O IBARROLA HILARIO. Datos registrales. T 1281 , F 100, S8, H SS 1209, I/A 29 (12.03.09).