Buscador CIF Logo

Actos BORME Summa Insurance Correduria De Seguros Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Summa Insurance Correduria De Seguros Sl

Actos BORME Summa Insurance Correduria De Seguros Sl - B83799635

Tenemos registrados 82 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Summa Insurance Correduria De Seguros Sl con CIF B83799635

馃敊 Perfil de Summa Insurance Correduria De Seguros Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Summa Insurance Correduria De Seguros Sl

01 de Diciembre de 2023
Revocaciones. Apoderado: CARRASCO PEREZ RAFAEL. Datos registrales. T 32787 , F 97, S 8, H M 341001, I/A 81 (24.11.23).

03 de Octubre de 2023
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 96, S 8, H M 341001, I/A 80 (26.09.23).

03 de Abril de 2023
Nombramientos. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Datos registrales. T 32787 , F 95, S 8, H M 341001, I/A 77 (27.03.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;BARQUERO ESTEVAN JOAQUIN. Datos registrales. T 32787 ,F 96, S 8, H M 341001, I/A 78 (27.03.23).

Nombramientos. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Datos registrales. T 32787 , F 96, S 8, H M 341001, I/A 79 (27.03.23).

02 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 95, S 8, H M 341001, I/A 76 (25.11.22).

31 de Octubre de 2022
Revocaciones. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32787 , F 93, S 8, H M 341001, I/A 73 (24.10.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;BARQUERO ESTEVAN JOAQUIN. Datos registrales. T 32787 ,F 93, S 8, H M 341001, I/A 74 (24.10.22).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;BARQUERO ESTEVAN JOAQUIN. Datos registrales. T 32787 ,F 94, S 8, H M 341001, I/A 75 (24.10.22).

19 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Sol.: FRAILE DE PAZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 32787 , F 90, S 8, H M 341001, I/A 70 (12.07.22).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CEBALLOS LANTERO JOSE MARIA;GOMEZ VICENTE ESTHER. Nombramientos. Apo.Man.Soli:GOMEZ VICENTE ESTHER. Apo.Manc.: BARQUERO ESTEVAN JOAQUIN;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 32787 , F 90, S 8, H M 341001, I/A 71 (12.07.22).

Nombramientos. Apoderado: CANTERO ROJO PATRICIA. Datos registrales. T 32787 , F 92, S 8, H M 341001, I/A 72 (12.07.22).

07 de Junio de 2022
Nombramientos. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32787 , F 90, S 8, H M 341001, I/A 69 (31.05.22).

27 de Abril de 2022
Cambio de domicilio social. C/ ORENSE 68 - PLANTA 13 (MADRID). Datos registrales. T 32787 , F 82, S 8, H M 341001, I/A 64(20.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: FRAILE DE PAZ ALEJANDRO. Datos registrales. T 32787 , F 83, S 8, H M 341001, I/A 65 (20.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: BUENO BUENO SANTIAGO FRANCISCO. Datos registrales. T 32787 , F 85, S 8, H M 341001, I/A 66(20.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: CASTRO FORNIELES JUAN CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F 86, S 8, H M 341001, I/A 67(20.04.22).

Nombramientos. Apo.Sol.: MISSIERI SARA CELLATO. Datos registrales. T 32787 , F 88, S 8, H M 341001, I/A 68 (20.04.22).

30 de Marzo de 2022
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;RODRIGUEZ FERNANDEZDULCE MARIA. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 32787 , F 82, S 8, H M 341001, I/A 63(23.03.22).

22 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: CARRASCO PEREZ RAFAEL. Datos registrales. T 32787 , F 80, S 8, H M 341001, I/A 61 (15.10.21).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CARRASCO HIDALGO RAFAEL. Apoderado: RONDAN PANTOJA JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 32787 , F 82, S 8, H M 341001, I/A 62 (15.10.21).

21 de Octubre de 2021
Nombramientos. Apoderado: GIRALT RAMIREZ JESUS. Datos registrales. T 32787 , F 78, S 8, H M 341001, I/A 60 (14.10.21).

21 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 78, S 8, H M 341001, I/A 59 (14.09.21).

01 de Marzo de 2021
Nombramientos. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO. Datos registrales. T 32787 , F 76, S 8, H M 341001, I/A 57(22.02.21).

Nombramientos. Apoderado: MARCOS RUEDA LAURENTINO;LOPEZ MARTINEZ JOSE MANUEL;VARGAS GONZALEZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 32787 , F 78, S 8, H M 341001, I/A 58 (22.02.21).

26 de Febrero de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: HURTADO DE MENDOZA WAHROLEN ALFONSO. Apo.Sol.: RUIZ GARRIDO MARIO. Apoderado:CASTILLO CAVANILLES PEDRO;CASADO OLIVER RAMON. Datos registrales. T 32787 , F 73, S 8, H M 341001, I/A 55 (19.02.21).

Nombramientos. Apoderado: BARQUERO ESTEVAN JOAQUIN;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T32787 , F 74, S 8, H M 341001, I/A 56 (19.02.21).

28 de Septiembre de 2020
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 73, S 8, H M 341001, I/A 54 (21.09.20).

12 de Marzo de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GRAU GRAU JOSE LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: GUILLEN TORRES TOMAS. Datosregistrales. T 32787 , F 72, S 8, H M 341001, I/A 53 ( 5.03.20).

13 de Noviembre de 2019
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEBALLOS LANTERO JOSE MARIA;GOMEZ VICENTE ESTHER. Datos registrales. T 32787 , F70, S 8, H M 341001, I/A 52 ( 6.11.19).

06 de Noviembre de 2019
Revocaciones. Apoderado: CANALES CALANCHA PEDRO. Apo.Man.Soli: CEBALLOS LANTERO JOSE MARIA;VICENTE GOMEZESTHER;HURTADO DE MENDOZA WAHROLEN ALFONSO. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GARCELAN ERNESTO. Datos registrales. T32787 , F 70, S 8, H M 341001, I/A 51 (29.10.19).

18 de Septiembre de 2019
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 70, S 8, H M 341001, I/A 50 (11.09.19).

06 de Agosto de 2019
Nombramientos. Apo.Sol.: BANDERAS ORTIZ MARIA. Datos registrales. T 32787 , F 68, S 8, H M 341001, I/A 49 (30.07.19).

29 de Enero de 2019
Revocaciones. Apoderado: GIL SAMPERE MIRIAM. Apo.Sol.: BATOR LAREQUI RAUL. Datos registrales. T 32787 , F 66, S 8, H M341001, I/A 47 (22.01.19).

Nombramientos. Apo.Sol.: RODRIGUEZ GARCELAN ERNESTO. Datos registrales. T 32787 , F 67, S 8, H M 341001, I/A 48(22.01.19).

25 de Junio de 2018
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ GARCIA EVA ROCIO. Datos registrales. T 32787 , F 65, S 8, H M 341001, I/A 46(18.06.18).

16 de Febrero de 2018
Nombramientos. Apoderado: RONDAN PANTOJA JUAN CARLOS. Datos registrales. T 32787 , F 63, S 8, H M 341001, I/A 45 (9.02.18).

08 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: CASADO OLIVER RAMON. Datos registrales. T 32787 , F 61, S 8, H M 341001, I/A 44 ( 1.06.17).

09 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apoderado: RINCON SECO OSCAR. Datos registrales. T 32787 , F 59, S 8, H M 341001, I/A 42 (27.04.17).

Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ GARCIA MARIA DEL MAR. Nombramientos. Apoderado: MILLA VALLEJO FRANCISCOJOSE. Datos registrales. T 32787 , F 60, S 8, H M 341001, I/A 43 (27.04.17).

26 de Enero de 2017
Reelecciones. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 32787 , F 59, S 8, H M 341001, I/A 41 (18.01.17).

14 de Septiembre de 2016
Nombramientos. Apoderado: CASTILLO CAVANILLES PEDRO. Datos registrales. T 32787 , F 58, S 8, H M 341001, I/A 40 (5.09.16).

26 de Mayo de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: BATOR LAREQUI RAUL. Datos registrales. T 32787 , F 56, S 8, H M 341001, I/A 39 (17.05.16).

28 de Abril de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL. Apo.Sol.: RODRIGUEZ TORTOSA LUIS. Apo.Manc.: DEL RIEGOVALLEDOR MIGUEL;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL. Apo.Man.Soli: SAMPEDRO ALBA JAVIER.Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL. Apoderado: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;LOPEZ ALDABA I脩AKI;DEL RIEGOVALLEDOR MIGUEL;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;PEREZ ERROZ MARIA IRACHE;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL. Otrosconceptos: Revocados los poderes conferidos a Don Miguel del Riego Valledor en escritura otorgada el 27 de enero de 2010 ante elnotario de Madrid Don Rodrigo Tena Arregui, n煤mero 192 de protocolo y el otorgado el 13 de julio de 2012 ante el notario de MadridDon Inigo Casla Uriarte, n煤mero 816 de protocolo. Datos registrales. T 32787 , F 55, S 8, H M 341001, I/A 38 (15.04.16).

21 de Abril de 2016
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ GARCIA MARIA DEL MAR. Datos registrales. T 32787 , F 51, S 8, H M 341001, I/A 35(13.04.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ GARRIDO MARIO. Datos registrales. T 32787 , F 52, S 8, H M 341001, I/A 36 (13.04.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: MONLLAU CRUZ ELOI FERRAN. Datos registrales. T 32787 , F 54, S 8, H M 341001, I/A 37 (13.04.16).

13 de Enero de 2016
Otros conceptos: La entidad absorbida SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS SL, domiciliada enVinzaroz, Castell贸n, inscrita en el Registro Mercantil de Castell贸n, hoja CS-2167, CIF B-12309548. Fusi贸n por absorci贸n.Sociedades absorbidas: SUMMA INSURANCE MEDITERRANEO CORREDURIA DE SEGUROS. Datos registrales. T 32787 , F 48,S 8, H M 341001, I/A 34 (30.12.15).

23 de Marzo de 2015
Nombramientos. Apoderado: GIL SAMPERE MIRIAM. Datos registrales. T 32787 , F 46, S 8, H M 341001, I/A 33 (12.03.15).

05 de Noviembre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: BLANCO FOLCH MARIUS. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;DEL RIEGOVALLEDOR MIGUEL. Datos registrales. T 28644 , F 35, S 8, H M 341001, I/A 29 (28.10.14).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: CASTILLO MOLINA ALEJANDRO. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGASGONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 35, S 8, H M 341001, I/A 30 (28.10.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: HURTADO DE MENDOZA WAHROLEN ALFONSO. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 36, S 8, H M 341001, I/A 31 (28.10.14).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GRAU GRAU JOSE LUIS. Apo.Manc.: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;HURTADO DEMENDOZA WAHROLEN ALFONSO. Datos registrales. T 28644 , F 38, S 8, H M 341001, I/A 32 (28.10.14).

14 de Octubre de 2014
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SUMMA INSURANCE SUROESTE CORREDURIA DE SEGUROS SL. Datosregistrales. T 28644 , F 33, S 8, H M 341001, I/A 28 ( 6.10.14).

17 de Enero de 2014
Revocaciones. Auditor: BDO AUDITORES SL. Nombramientos. Auditor: GRANT THORNTON SLP. Datos registrales. T 28644 ,F 33, S 8, H M 341001, I/A 27 ( 9.01.14).

27 de Marzo de 2013
Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 28644 , F 33, S 8, H M 341001, I/A 26 (19.03.13).

07 de Marzo de 2013
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GIL PIEDRA FRANCISCO. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 33, S 8, H M 341001, I/A 25 (27.02.13).

18 de Diciembre de 2012
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CEBALLOS LANTERO JOSE MARIA;VICENTE GOMEZ ESTHER. Datos registrales. T 28644 , F32, S 8, H M 341001, I/A 24 (10.12.12).

09 de Agosto de 2012
Revocaciones. Apoderado: CLOP GARCIA JORDI. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BLANCO FOLCH MARIUS. Apo.Manc.: DELRIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 29, S 8, H M 341001, I/A 22(30.07.12).

Cambio de domicilio social. PASEO DE LA CASTELLANA 143 3& B (MADRID). Datos registrales. T 28644 , F 32, S 8, H M341001, I/A 23 (30.07.12).

25 de Abril de 2012
Revocaciones. Apoderado: RUIZ NAVASCUES YOLANDA. Nombramientos. Apoderado: PEREZ ERROZ MARIA IRACHE;DELRIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 27, S 8, H M 341001, I/A 21(13.04.12).

27 de Diciembre de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SUMMA INSURANCE MAYA CORREDURIA DE SEGUROS SL. Datos registrales.T 28644 , F 25, S 8, H M 341001, I/A 20 (15.12.11).

03 de Agosto de 2011
Otros conceptos: ABSORBENTE: SUMMA INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS SL, domiciliada en Madrid, calle Capit谩nHaya 38, inscrita en este Registro al tomo 19.436, folio 25, hoja n煤mero M-341.001, CIF B-83.799.635. Datos registrales. T 19436 , F27, S 8, H M 341001, I/A 1 M (21.07.11).

17 de Junio de 2011
Nombramientos. Apoderado: CANALES CALANCHA PEDRO. Datos registrales. T 28644 , F 25, S 8, H M 341001, I/A 19 (3.06.11).

10 de Junio de 2011
Revocaciones. Apo.Manc.: GAIUS KING ROBERT. Apo.Sol.: BARREIRA TURNES JOSE ANTONIO CARLOS. Datos registrales. T28644 , F 23, S 8, H M 341001, I/A 17 (31.05.11).

Nombramientos. Apoderado: RUIZ NAVASCUES YOLANDA;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSEANTONIO. Datos registrales. T 28644 , F 23, S 8, H M 341001, I/A 18 (31.05.11).

30 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: CLOP GARCIA JORDI;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 27390 , F 189, S 8, H M 341001, I/A 15 (18.03.11).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ALDABA I脩AKI;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO.Datos registrales. T 28644 , F 21, S 8, H M 341001, I/A 16 (18.03.11).

09 de Marzo de 2011
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: SUMMA INSURANCE ALDAVE CORREDURIA DE SEGUROS SL. SUMMAINSURANCE ERPA CORREDURIA DE SEGUROS SL. SUMMA INSURANCE TECHNIRISK CORREDURIA DE SEGUROS S. Datosregistrales. T 27390 , F 185, S 8, H M 341001, I/A 14 (24.02.11).

23 de Diciembre de 2010
Otros conceptos: SUBSANACION DE LA AMPLIACION DE CAPITAL ACORDADA EL 21 DE OCTUBRE DE 2010, EN CUANTO A

02 de Diciembre de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 10.177.303,00 Euros. Resultante Suscrito: 10.180.313,00 Euros. Datos registrales. T 27390 , F 184,S 8, H M 341001, I/A 12 (19.11.10).

30 de Noviembre de 2010
Otros conceptos: CANCELACION DEL PROYECTO DE FUSION DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010, DEPOSITADO EL DIA 20 DEAGOSTO DE 2010.FECHA DE CANCELACION 20 DE OCTUBRE DE 2010.DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTACOMPA脩IA, SIENDO LAS SOCIEDADES ABSORBIDAS LAS SIGUIENTES "SUMMA INSURANCE ALDAVE CORREDURIA DESEGUROS SL", "SUMMA INSURANCE ERPA CORREDURIA DE SEGUROS SL" Y "SUMMA INSURANCE TECHNIRISKCORREDURIA DE SEGUROS SL". Datos registrales. T 19436 , F 26, S 8, H M 341001, I/A 1 M (18.11.10).

31 de Agosto de 2010
Otros conceptos: SOCIEDAD ABSORBENTE SUMMA INSURANCE CORREDURIA DE SEGUROS SL DOMICILIADA EN MADRIDCAPITAN HAYA 38, INSCRITA AL TOMO 19436, FOLIO 25. SOCIEDAD ABSORBIDA: SUMMA INSURANCE ALDAVECORREDURIA DE SEGUROS SLU, DOMICILIADA EN PAMPLONA, ITURRAMA 13 INSCRITA AL TOMO 857, FOLIO 61SOCIEDADABSORBIDA: SUMMA INSURANCE ERPA CORREDURIA DE SEGUROS SLU, DOMICILIADA EN PAMPLONA, BARRIO VERDE 1,INSCRITA AL TOMO 104, FOLIO 26. Datos registrales. T 19436 , F 26, S 8, H M 341001, I/A 1-M (20.08.10).

15 de Abril de 2010
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ANGEL HERNANDEZ SOTO CORREDURIA DE SEGUROS SL. Datos registrales.T 27390 , F 183, S 8, H M 341001, I/A 11 (30.03.10).

17 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VARGAS GONZALEZ JOSE ANTONIO;DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;LARREA QUINTANABEGO脩A. Apo.Manc.: GAUIS KING ROBERT. Apo.Sol.: BARREIRA TURNES JOSE ANTONIO CARLOS;RODRIGUEZ TORTOSALUIS. Datos registrales. T 19436 , F 32, S 8, H M 341001, I/A 4 ( 5.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: ZAMORA PARDO SALVADOR. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27390 , F 172, S 8, H M 341001, I/A 5 ( 5.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CARRASCO HIDALGO RAFAEL. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGASGONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27390 , F 174, S 8, H M 341001, I/A 6 ( 5.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GUINEA GONZALEZ JOSE ANTONIO. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGASGONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27390 , F 176, S 8, H M 341001, I/A 7 ( 5.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: SAMPEDRO ALBA JAVIER. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZ

Nombramientos. Apo.Man.Soli: GIL PIEDRA FRANCISCO. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGAS GONZALEZJOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27390 , F 179, S 8, H M 341001, I/A 9 ( 5.03.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CASTILLO MOLINA ALEJANDRO. Apo.Manc.: DEL RIEGO VALLEDOR MIGUEL;VARGASGONZALEZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 27390 , F 181, S 8, H M 341001, I/A 10 ( 5.03.10).

04 de Diciembre de 2009
Otros conceptos: DEPOSITO DEL PROYECTO DE FUSION DE ESTA COMPA脩IA , SIENDO LA SOCIEDAD QUE EN SU DIASERA LA ABSORBIDA " ANGEL HERNANDEZSOTO CORREDURIA DE SEGUROS SL " .- Datos registrales. T 19436 , F 25, S 8, HM 341001, I/A 1M (24.11.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n