Buscador CIF Logo

Actos BORME Sunco Energias Renovables Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sunco Energias Renovables Sl

Actos BORME Sunco Energias Renovables Sl - B64805724

Tenemos registrados 18 Actos BORME del Registro Mercantil de Barcelona para Sunco Energias Renovables Sl con CIF B64805724

馃敊 Perfil de Sunco Energias Renovables Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Barcelona

Actos BORME de Sunco Energias Renovables Sl

19 de Marzo de 2014
Extinci贸n. Datos registrales. T 41974 , F 123, S 8, H B 368110, I/A 20 (12.03.14).

22 de Agosto de 2013
Nombramientos. APOD.MANCOMU: MARTINEZ PEON FERNANDO. APOD.SOL/MAN: ARTIGA AMAT ANTONIO.APOD.MANCOMU: MARTINEZ MARTIN SERGIO;RIBAS PEREZ OSCAR;MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 41974 , F 123, S 8, H B 368110, I/A 19 (13.08.13).

31 de Mayo de 2013
Revocaciones. CONSEJERO: MARTINEZ MARTIN SERGIO. Datos registrales. T 41974 , F 123, S 8, H B 368110, I/A 18(23.05.13).

04 de Febrero de 2013
Cambio de domicilio social. PQ MAS BLAU C/BERGUEDA 1 A3-C4 PL.BAJA ESC.A (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datosregistrales. T 41974 , F 123, S 8, H B 368110, I/A 17 (25.01.13).

29 de Junio de 2012
Nombramientos. APODERADO: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL. Datos registrales. T 41974 , F 123, S 8, H B 368110, I/A16 (18.06.12).

09 de Mayo de 2011
Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, SOCIO UNICO: "SUNCO ENERGY SL". Datos registrales. T 41974 , F 122, S 8, HB 368110, I/A 15 (26.04.11).

15 de Abril de 2011
Revocaciones. APODERADO: MESTRE LAJARIN VICTOR;BONET PEDROL JAIME. Datos registrales. T 41974 , F 122, S 8, H B368110, I/A 14 ( 6.04.11).

31 de Enero de 2011
Revocaciones. CONSEJERO: MESTRE FERNANDEZ JOSE. PRESIDENTE: MESTRE FERNANDEZ JOSE. CONSEJERO:MESTRE LAJARIN VICTOR. Nombramientos. PRESIDENTE: MARTINEZ PEON FERNANDO. Datos registrales. T 41974 , F 122,S 8, H B 368110, I/A 13 (18.01.11).

25 de Noviembre de 2010
Nombramientos. APODERADO: MORANTE GONZALEZ JUAN MANUEL;MARTINEZ MARTIN SERGIO;RIBAS PEREZ OSCAR.Datos registrales. T 41974 , F 121, S 8, H B 368110, I/A 12 (12.11.10).

06 de Agosto de 2010
Otros conceptos: RECTIFICACION DE LA INSCRIPCION 9 EN CUANTO A QUE EL NOMBRECORRECTO DEL CONSEJERONOMBRADO COMO MICHAEL JOSEPH SCHIMDLIM, ES:"MICHEL JOSEPH SCHMIDLIN". Datos registrales. T 41974 , F 121, S 8,H B 368110, I/A 11 (27.07.10).

08 de Julio de 2010
Revocaciones. APODERADO: MESTRE LAJARIN VICTOR;MARTINEZ MARTIN SERGIO;AOS REMON JORDI. Nombramientos.APODERADO: MESTRE LAJARIN VICTOR;MARTINEZ PEON FERNANDO;MARTINEZ MARTIN SERGIO;BONET PEDROLJAIME;RIBAS PEREZ OSCAR. Datos registrales. T 40429 , F 23, S 8, H B 368110, I/A 10 (23.06.10).

28 de Junio de 2010
Revocaciones. ADM.UNICO: MESTRE FERNANDEZ JOSE. Nombramientos. CONSEJERO: DOMINGO LOPEZ MIQUEL;VI脩ASBARCELO JOAQUIN;MICHAEL JOSEPH SCHIMDLIM;MARTINEZ PEON FERNANDO;MESTRE FERNANDEZ JOSE. PRESIDENTE:MESTRE FERNANDEZ JOSE. CONSEJERO: MESTRE LAJARIN VICTOR;MARTINEZ MARTIN SERGIO. SECR.NO CONS:FONDEVILA NADAL JAVIER. Modificaciones estatutarias. ART.15.- ATRIBUCION DE CARACTER GRATUITO AL CARGO DEADMINISTRADOR. Cambio de domicilio social. CL SOLSONES NUM.2 B3 (PRAT DE LLOBREGAT (EL)). Datos registrales. T40429 , F 22, S 8, H B 368110, I/A 9 (16.06.10).

18 de Mayo de 2010
Otros conceptos: AL HABERSE MODIFICADO EL IMPORTE DE LA AMPLIACION DE CAPITAL Y PRIMA DE EMISION QUERESULTA DE LAS INSCRIPCIONES 6 Y 7,SE AMPLIA EL CAPITAL SOCIAL EN "1510 EUROS", QUEDANDO ESTABLECIDO EN"144.226 EUROS". Datos registrales. T 40429 , F 21, S 8, H B 368110, I/A 8 ( 6.05.10).

10 de Marzo de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 28.543,00 Euros. Resultante Suscrito: 142.716,00 Euros. Datos registrales. T 40429 , F 20, S 8, H B368110, I/A 7 (25.02.10).

26 de Enero de 2010
Ampliaci贸n de capital. Capital: 4.567,00 Euros. Resultante Suscrito: 114.173,00 Euros. Datos registrales. T 40429 , F 20, S 8, H B368110, I/A 6 (13.01.10).

30 de Septiembre de 2009
Ampliaci贸n de capital. Capital: 49.606,00 Euros. Resultante Suscrito: 109.606,00 Euros. Datos registrales. T 40429 , F 18, S 8, H B368110, I/A 5 (18.09.09).

04 de Mayo de 2009
Nombramientos. APODERADO: MARTINEZ MARTIN SERGIO;AOS REMON JORDI. Datos registrales. T 40429 , F 17, S 8, H B368110, I/A 4 (21.04.09).

26 de Febrero de 2009
Revocaciones. APODERADO: LLOHIS BATISTA ROGER. Datos registrales. T 40429 , F 17, S 8, H B 368110, I/A 3 (16.02.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n