Actos BORME de Superficies Decoradas Sociedad Anonima
19 de Septiembre de 2022Reelecciones. Auditor: CAVALMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 146, S 8, H V 10631, I/A 50 (12.09.22).
14 de Octubre de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL;ARISTOY CENCILLO MARIO;GOMEZ - LECHON MONFORTARTUROPresidente: GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL. Secretario: ARISTOY CENCILLO MARIO. Nombramientos.Apoderado: GOMEZ LECHON CUADRADO MARIA DOLORES. Consejero: ARISTOY CENCILLO MARIO;GOMEZ LECHONMONFORT RAFAEL;GOMEZ LECHON CUADRADO MARIA DOLORES. Presidente: GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL.Secretario: ARISTOY CENCILLO MARIO. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 146, S 8, H V 10631, I/A 49 ( 5.10.21).
21 de Febrero de 2019Reelecciones. Auditor: CAVALMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 145, S 8, H V 10631, I/A 48 (14.02.19).
03 de Octubre de 2016Reelecciones. Consejero: ARISTOY CENCILLO MARIO;GOMEZ - LECHON MONFORT ARTURO;GOMEZ LECHON MONFORTRAFAELSecretario: ARISTOY CENCILLO MARIO. Presidente: GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL. Otros conceptos: Artículo24.- Plazo.- Todo administrador ejercerá su cargo por seis años y podrá ser reelegido, una o más veces, con el mismo límite de plazo.El nombramiento de administrador, sin fijación de plazo, se entenderá efectuado por el máximo legal de seis años. Datos registrales.T 3998, L 1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 47 (26.09.16).
03 de Diciembre de 2015Nombramientos. Apoderado: ARISTOY CENCILLO MARIO. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 46(26.11.15).
24 de Noviembre de 2015Nombramientos. Auditor: CAVALMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 45(17.11.15).
26 de Agosto de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ LECHON MOLINER JUAN. Secretario: GOMEZ LECHON MOLINER JUAN.Nombramientos. Consejero: ARISTOY CENCILLO MARIO. Secretario: ARISTOY CENCILLO MARIO. Datos registrales. T 3998, L1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 44 (19.08.15).
11 de Agosto de 2014Ceses/Dimisiones. Secretario: ARISTOY CENCILLO MARIO. Nombramientos. Secretario: GOMEZ LECHON MOLINER JUAN.Datos registrales. T 3998, L 1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 43 ( 4.08.14).
05 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: ARISTOY CENCILLO MARIO. Datos registrales. T 3998, L 1310, F 144, S 8, H V 10631, I/A 42(29.05.14).
20 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ LECHON CUADRADO ALICIA. Nombramientos. Consejero: GOMEZ - LECHONMONFORT ARTURO. Datos registrales. T 3452, L 765, F 183, S 8, H V 10631, I/A 41 (13.11.13).
09 de Agosto de 2013Nombramientos. Auditor: CAVALMAR AUDITORES SLP. Datos registrales. T 3452, L 765, F 183, S 8, H V 10631, I/A 40 ( 2.08.13).
21 de Junio de 2013Modificaciones estatutarias. ARTICULO 14.-CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL. Página web de la sociedad. Creaciónde la página web corporativa: www.sudesa.es. Datos registrales. T 3452, L 765, F 183, S 8, H V 10631, I/A 38 (14.06.13).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BELTRAN FERRER EDUARDO. Presidente: BELTRAN FERRER EDUARDO. Nombramientos.Consejero: GOMEZ LECHON CUADRADO ALICIA. Presidente: GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL. Datos registrales. T 3452, L765, F 183, S 8, H V 10631, I/A 39 (14.06.13).
16 de Agosto de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ LECHON MOLINER LUIS. Presidente: GOMEZ LECHON MOLINER LUIS. Consejero:GOMEZ LECHON MONFORT RAFAEL;GOMEZ LECHON MOLINER JUAN VICENTE. Nombramientos. Consejero: GOMEZLECHON MONFORT RAFAEL;BELTRAN FERRER EDUARDO;GOMEZ LECHON MOLINER JUAN. Presidente: BELTRAN FERREREDUARDO. Datos registrales. T 3452, L 765, F 182, S 8, H V 10631, I/A 37 ( 4.08.11).
03 de Agosto de 2010Reelecciones. Aud.Supl.: IRANZO IBAÑEZ JULIO. Auditor: GARCIA ARENAS JOSE JACOBO. Datos registrales. T 3452, L 765, F182, S 8, H V 10631, I/A 36 (23.07.10).
12 de Agosto de 2009Reelecciones. Auditor: GARCIA ARENAS JOSE JACOBO. Aud.Supl.: IRANZO IBAÑEZ JULIO. Datos registrales. T 3452, L 765, F182, S 8, H V 10631, I/A 35 ( 3.08.09).