Buscador CIF Logo

Actos BORME Supermercados Coalve Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Supermercados Coalve Sl

Actos BORME Supermercados Coalve Sl - B80474893

Tenemos registrados 15 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Supermercados Coalve Sl con CIF B80474893

馃敊 Perfil de Supermercados Coalve Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Supermercados Coalve Sl

29 de Febrero de 2016
Otros conceptos: QUEDA CERRADA LA HOJA DE ESTA SOCIEDAD QUEDANDO EXTINGUIDA Y HABIENDOSE CANCELADOTODOS SUS ASIENTOS POR HABER SIDO ABSORBIDA POR OTRA DE BARCELONA, CONDIS SUPERMERCATS SA , DEACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 233.2 DEL RRM. Datos registrales. T 22319 , F 116, S 8, H M 84600, I/A 46(18.02.16).

19 de Noviembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 116, S 8, H M 84600, I/A 45 (11.11.14).

12 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 116, S 8, H M 84600, I/A 44 ( 4.11.13).

14 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: AGELET DE SARACIBAR BACH BORJA. Datos registrales. T 22319 , F 115, S 8, H M 84600, I/A 43 (6.05.13).

25 de Abril de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: HERNANDEZ VELAZQUEZ MARCOS;BARATAS MATALLANAS VANESA;JIMENO PESCADORRAFAEL. Datos registrales. T 22319 , F 114, S 8, H M 84600, I/A 41 (17.04.13).

Revocaciones. Apoderado: JIMENO PESCADOR RAFAEL;MARSAL BONET ENRIC;PI脩ANA SANCHEZ COLORADO JOSEPMANUEL;CASTELLANO LLASTARRY JOSE MANUEL;HERNANDEZ VELAZQUEZ MARCOS;AGELET DE SARACIBAR BACHBORJA. Apo.Manc.: HERNANDEZ VELAZQUEZ MARCOS;BARATAS MATALLANAS VANESA;JIMENO PESCADOR RAFAEL.Apoderado: CONDAL BARGOS MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 22319 , F 114, S 8, H M 84600, I/A 42 (17.04.13).

23 de Abril de 2013
Revocaciones. Apoderado: ROIG JUYOL JORDI. Datos registrales. T 22319 , F 114, S 8, H M 84600, I/A 40 (15.04.13).

05 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: CONDAL ESCUDE JAVIER;CONDAL ESCUDE ANTONI;CONDAL ESCUDE RAMON.Nombramientos. Adm. Solid.: CONDAL GUIRADO MARIA DEL CARMEN;CONDAL BARGOS MARIA DEL PILAR;CONDALTORRENS JOSEP. Datos registrales. T 22319 , F 113, S 8, H M 84600, I/A 39 (26.03.13).

13 de Noviembre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 113, S 8, H M 84600, I/A 38 (31.10.12).

30 de Noviembre de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 113, S 8, H M 84600, I/A 37 (18.11.11).

23 de Mayo de 2011
Revocaciones. Apoderado: ORTIZ DIAZ ANTONIO;ROMERO JIMENEZ OSCAR;JIMENO PESCADOR RAFAEL. Datos registrales.T 22319 , F 113, S 8, H M 84600, I/A 36 (11.05.11).

15 de Marzo de 2011
Nombramientos. Apoderado: CONDAL BARGOS MARIA DEL PILAR. Datos registrales. T 22319 , F 111, S 8, H M 84600, I/A 35 (3.03.11).

24 de Noviembre de 2010
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 111, S 8, H M 84600, I/A 34 (12.11.10).

26 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22319 , F 111, S 8, H M 84600, I/A 33 (16.11.09).

01 de Julio de 2009
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.709.500,00 Euros. Resultante Suscrito: 309.515,00 Euros. Datos registrales. T 22319 ,F 110, S 8, H M 84600, I/A 32 (18.06.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n