Actos BORME de Supsa Supermercats Pujol Sl
08 de Noviembre de 2023Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 317 , F 222, S 8, H L 3077, I/A 52 (30.10.23).
22 de Enero de 2021Reelecciones. Consejero: ONCINS PUJOL JORDI;ONCINS PUJOL RAFAEL;ONCINS PUJOL LOURDES;PUJOL DITTMAR ISABELVIVIANA;PUJOL DITTMAR SILVIA;DE GROEN MARCUS BERNARDUS MARIA. Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.:
10 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: AUDIRISK-CONTROL SL. Datos registrales. T 317 , F 221, S 8, H L 3077, I/A 50 (30.10.20).
16 de Julio de 2019Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ CASCALES FRANCISCO;GALINDO MALLON OLGA. Datos registrales. T 317 , F 221, S 8,H L 3077, I/A 49 ( 8.07.19).
31 de Mayo de 2019Ceses/Dimisiones. Presidente: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Vicepresid.: ONCINS PUJOL JORDI. Nombramientos.Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.: PUJOL DITTMAR SILVIA. Datos registrales. T 317 , F 176, S 8, H L 3077, I/A 48(20.05.19).
02 de Agosto de 2017Reelecciones. Auditor: AUDIRISK-CONTROL SL. Datos registrales. T 317 , F 176, S 8, H L 3077, I/A 47 (24.07.17).
14 de Julio de 2017Revocaciones. Apoderado: ONCINS PUJOL RAFAEL;ZUBIAUR MARTINEZ XAVIER;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA.Apo.Manc.: ZUBIAUR MARTINEZ XAVIER;ONCINS PUJOL RAFAEL;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Nombramientos.Apoderado: GALINDO MALLON OLGA;ONCINS PUJOL RAFAEL;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Datos registrales. T 317 , F176, S 8, H L 3077, I/A 46 ( 7.07.17).
20 de Abril de 2017Ceses/Dimisiones. Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Nombramientos.Presidente: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Vicepresid.: ONCINS PUJOL JORDI. Datos registrales. T 317 , F 175, S 8, H L3077, I/A 45 (11.04.17).
02 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: DE GROEN MARCUS BERNARDUS MARIA;ONCINS PUJOL LOURDES;ONCINS PUJOLRAFAEL;ONCINS PUJOL JORDI;PUJOL DITTMAR SILVIA;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA;FARRERO BADIA ESTEBAN.Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Nombramientos. Consejero: ONCINS PUJOLJORDI;ONCINS PUJOL RAFAEL;ONCINS PUJOL LOURDES;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA;PUJOL DITTMAR SILVIA;DEGROEN MARCUS BERNARDUS MARIA. Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA.Otros conceptos: Queda establecido en seis el número de miembros del Consejo de Administración. Datos registrales. T 317 , F174, S 8, H L 3077, I/A 44 (25.11.16).
21 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: PUJOL SOLANES RAFAEL. Presidente: PUJOL SOLANES RAFAEL. Consejero: PUJOLSOLANES RAFAEL. Vicepresid.: ONCINS PUJOL JORDI. Nombramientos. Consejero: DE GROEN MARCUS BERNARDUSMARIA. Presidente: ONCINS PUJOL JORDI. Vicepresid.: PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Datos registrales. T 317 , F 173, S 8,H L 3077, I/A 42 (14.07.15).
Nombramientos. Apoderado: PUJOL SOLANES RAFAEL. Datos registrales. T 317 , F 173, S 8, H L 3077, I/A 43 (14.07.15).
16 de Febrero de 2015Nombramientos. Auditor: AUDIRISK-CONTROL SL. Datos registrales. T 317 , F 173, S 8, H L 3077, I/A 41 ( 5.02.15).
12 de Marzo de 2014Nombramientos. Vicepresid.: ONCINS PUJOL JORDI. Modificaciones estatutarias. Modificación el artículo 14º de los estatutossociales, párrafos 13º, 16º, 17º y 18º.. Otros conceptos: Ratifican en el cargo de consejero-delegado a Don Rafael Pujol Solanes,quién ostentará con carácter amplio todas las facultades del Consejo de Administración que no sean legalmente indelegables, y con lasúnicas limitaciones establecidas en los estatutos sociales según última modificación aprobada. Datos registrales. T 317 , F 96, S 8, HL 3077, I/A 37 ( 4.03.14).
Revocaciones. Apoderado: ESQUERDA BAIGET XAVIER. Apo.Manc.: ESQUERDA BAIGET XAVIER. Datos registrales. T 317 , F97, S 8, H L 3077, I/A 38 ( 4.03.14).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ CASCALES FRANCISCO. Datos registrales. T 317 , F 97, S 8, H L 3077, I/A 39 (4.03.14).
Revocaciones. Apo.Manc.: ONCINS PUJOL RAFAEL;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA. Apoderado: ZUBIAUR MARTINEZXAVIER. Nombramientos. Apoderado: ONCINS PUJOL RAFAEL;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA;ZUBIAUR MARTINEZXAVIER. Apo.Manc.: ONCINS PUJOL RAFAEL;PUJOL DITTMAR ISABEL VIVIANA;ZUBIAUR MARTINEZ XAVIER. Datosregistrales. T 317 , F 98, S 8, H L 3077, I/A 40 ( 4.03.14).
07 de Febrero de 2014Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 317 , F 96, S 8, H L 3077, I/A 36 (31.01.14).
27 de Junio de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: ROSELLO HERRERO ROSA MARIA. Nombramientos. Apoderado: ZUBIAUR MARTINEZ XAVIER.Datos registrales. T 317 , F 95, S 8, H L 3077, I/A 35 (18.06.13).
18 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: BARRAU PONS SILVIA. Nombramientos. SecreNoConsj: JOVE RIS ANNA. Datosregistrales. T 317 , F 95, S 8, H L 3077, I/A 34 (11.04.13).
14 de Noviembre de 2012Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 317 , F 95, S 8, H L 3077, I/A 33 (31.10.12).
24 de Octubre de 2012Nombramientos. Apoderado: ONCINS FARRE ANTONIO. Datos registrales. T 317 , F 95, S 8, H L 3077, I/A 32 (11.10.12).
06 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: ONCINS FARRE ANTONIO;PUJOL SOLANES RAFAEL. Vicepresid.: ONCINS FARRE ANTONIO.Presidente: PUJOL SOLANES RAFAEL. Consejero: ONCINS PUJOL RAFAEL;ONCINS PUJOL JORDI;PUJOL DITTMAR ISABELVIVIANA;PUJOL DITTMAR SILVIA;ONCINS FARRE ANTONIO;PUJOL SOLANES RAFAEL. Nombramientos. Consejero: PUJOLSOLANES RAFAEL;ONCINS FARRE ANTONIO;ONCINS PUJOL RAFAEL;ONCINS PUJOL JORDI;PUJOL DITTMAR SILVIA;PUJOLDITTMAR ISABEL VIVIANA;FARRERO BADIA ESTEBAN. Presidente: PUJOL SOLANES RAFAEL. Con.Delegado: PUJOL SOLANESRAFAEL. Vicepresid.: ONCINS FARRE ANTONIO. Datos registrales. T 317 , F 32, S 8, H L 3077, I/A 29 (28.08.12).
Otros conceptos: Modifican los artículos 5º, 7º, 8º, 11º, 13º, 14º y 16º de los Estatutos Sociales, y añaden el artículo 14º bis en dichosEstatutos. Datos registrales. T 317 , F 33, S 8, H L 3077, I/A 30 (28.08.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: ONCINS FARRE ANTONIO. Vicepresid.: ONCINS FARRE ANTONIO. Nombramientos. Consejero:ONCINS PUJOL LOURDES. Datos registrales. T 317 , F 50, S 8, H L 3077, I/A 31 (28.08.12).
13 de Febrero de 2012Reducción de capital. Importe reducción: 14.128,20 Euros. Resultante Suscrito: 587.071,80 Euros. Datos registrales. T 317 , F 31,S 8, H L 3077, I/A 28 ( 2.02.12).
24 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 317 , F 31, S 8, H L 3077, I/A 27 (12.01.12).
06 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Manc.: ALEXANDRE GOMEZ JOSE ANTONIO. Nombramientos. Apo.Manc.: PUJOL DITTMAR ISABELVIVIANA;ROSELLO HERRERO ROSA MARIA. Datos registrales. T 315 , F 212, S 8, H L 3077, I/A 26 (27.08.10).
11 de Junio de 2010Ampliacion del objeto social. Prestación de servicios de bar y/o cafetería. Datos registrales. T 315 , F 212, S 8, H L 3077, I/A 25 (1.06.10).
09 de Junio de 2010Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 315 , F 211, S 8, H L 3077, I/A 24 (27.05.10).
29 de Septiembre de 2009Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 315 , F 211, S 8, H L 3077, I/A 22 (17.09.09).
Reelecciones. Auditor: AGUADO ANTONIJUAN Y SARRAGA SL. Datos registrales. T 315 , F 211, S 8, H L 3077, I/A 23 (17.09.09).