Actos BORME de Suratlantica De Gas Sl
27 de Abril de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: PEREZ VILLEGAS RAMON;CARRO CORTES MARIA DOLORES;CASTILLO PICON FERNANDO.Presidente: PEREZ VILLEGAS RAMON. Secretario: CARRO CORTES MARIA DOLORES. Cons.Del.Sol: PEREZ VILLEGASRAMON;CARRO CORTES MARIA DOLORES;CASTILLO PICON FERNANDO. Nombramientos. Adm. Solid.: CASTILLO PICONFERNANDO;CARRO CORTES MARIA DOLORES. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo deadministraci贸n a Administradores solidarios. Datos registrales. T 438 , F 115, S 8, H H 6155,H , I/ 9 .(17.04.12).
14 de Octubre de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: CASTILLO PICON FERNANDO;CAMPOS HORTA JOSE MANUEL;PEREZ VILLEGAS RAMON.Presidente: CASTILLO PICON FERNANDO. Secretario: CAMPOS HORTA JOSE MANUEL. Cons.Del.Sol: CASTILLO PICONFERNANDO;PEREZ VILLEGAS RAMON. Nombramientos. Consejero: PEREZ VILLEGAS RAMON;CARRO CORTES MARIADOLORES;CASTILLO PICON FERNANDO. Presidente: PEREZ VILLEGAS RAMON. Secretario: CARRO CORTES MARIADOLORES. Cons.Del.Sol: PEREZ VILLEGAS RAMON;CARRO CORTES MARIA DOLORES;CASTILLO PICON FERNANDO.Ampliacion del objeto social. La venta al por mayor y al por menor, dep贸sito, almacenamiento y distribuci贸n de productos derivadosdel petr贸leo, as铆 como el montaje, reparaci贸n, mantenimiento y revisi贸n de sus instalaciones y de instalaci贸n de energ铆a solar, aireacondicionado, calefacci贸n, y veh铆culos propulsados con Autog谩s y/. Cambio de domicilio social. POLIG INDUSTRIAL, CALLERIBERA DEL GUADIANA, PARCE (AYAMONTE). Datos registrales. T 438 , F 114, S 8, H H 6155,H , I/ 8 .( 3.10.11).