Actos BORME de Surdisauto Sl
06 de Julio de 2022Ceses/Dimisiones. LiqUnico: MARTINEZ GOMEZ CARLOS. Consejero: HUCH MIRO MONSERRAT;ANDREU ALONSO JOSELUIS;ANDREU HUCH GEORGINA. Con.Delegado: ANDREU ALONSO JOSE LUIS. Presidente: HUCH MIRO MONSERRAT.Vicepresid.: ANDREU ALONSO JOSE LUIS. Secretario: ANDREU HUCH GEORGINA. Revocaciones. Apo.Sol.: HUCH BOSCHSANTIAGO;MIRO JABAL ROSA. Apoderado: ANDREU ALONSO JOSE LUIS;MARTIN SANCHEZ ARACELI;LACASTA REVERTEALFREDO;HUCH MIRO MONTSERRAT. Apo.Man.Soli: MORALES RELA脩O ANA MARIA;MARTINEZ GOMEZ CARLOS;DIAZVAZQUEZ ANGEL. Apoderado: HUCH MIRO MONTSERRAT. Nombramientos. LiqUnico: MARTINEZ GOMEZ CARLOS. Otrosconceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Liquidador Unico. Disoluci贸n. Voluntaria.Extinci贸n. Datos registrales. T 6060 , F 121, S 8, H SE 72144, I/A 19 (27.06.22).
25 de Mayo de 2021Revocaciones. Apoderado: SAEZ GARCIA LUIS. Datos registrales. T 6060 , F 120, S 8, H SE 72144, I/A 18 (18.05.21).
04 de Marzo de 2021Ceses/Dimisiones. Consejero: SAEZ GARCIA LUIS. Secretario: SAEZ GARCIA LUIS. Nombramientos. Secretario: ANDREUHUCH GEORGINA. Datos registrales. T 6060 , F 120, S 8, H SE 72144, I/A 17 (24.02.21).
01 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: HUCH MIRO MONTSERRAT. Datos registrales. T 6060 , F 120, S 8, H SE 72144, I/A 16 (17.09.20).
27 de Febrero de 2020Revocaciones. Apoderado: ORTEGA BARRIO CARLOS. Otros conceptos: REVOCA el poder NO INSCRITO conferido a DONCARLOS ORTEGA BARRIOS escritura por el Notario de Barcelona, d. Ricardo Ferrer Marsal, el d铆a 11/07/ 2008, n潞 2885 protocolo, yEL NO INSCRITO del mismo se帽or otorgado ante el Notario de Hospitalet de Llobregat, Daniel Tello Blanco, el 2/02/18, n潞 191.- Datosregistrales. T 4586 , F 124, S 8, H SE 72144, I/A 15 (19.02.20).
08 de Enero de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: DIAZ VAZQUEZ ANGEL. Datos registrales. T 4586 , F 124, S 8, H SE 72144, I/A 14 (30.12.19).
03 de Junio de 2019Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ GOMEZ CARLOS. Datos registrales. T 4586 , F 123, S 8, H SE 72144, I/A 13(27.05.19).
13 de Marzo de 2017Revocaciones. Apoderado: PEREZ DE LA ROSA RUIZ JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 4586 , F 123, S 8, H SE 72144, I/A 12( 3.03.17).
08 de Abril de 2015Revocaciones. Apoderado: QUINTANA VILELLA FRANCISCO. Datos registrales. T 4586 , F 122, S 8, H SE 72144, I/A 11(31.03.15).
15 de Octubre de 2013Revocaciones. Apoderado: ALIA脩O RUIZ MANUEL. Datos registrales. T 4586 , F 122, S 8, H SE 72144, I/A 10 ( 7.10.13).
05 de Agosto de 2011Revocaciones. Apoderado: ROMERO DE LA HERA FRANCISCO. Datos registrales. T 4586 , F 122, S 8, H SE 72144, I/A 9(27.07.11).
24 de Mayo de 2011Nombramientos. Apo.Man.Soli: MORALES RELA脩O ANA MARIA. Datos registrales. T 4586 , F 121, S 8, H SE 72144, I/A 8(10.05.11).
17 de Agosto de 2009Nombramientos. Apoderado: HUCH MIRO MONTSERRAT. Datos registrales. T 4586 , F 121, S 8, H SE 72144, I/A 7 ( 3.08.09).
28 de Mayo de 2009Ceses/Dimisiones. Secretario: LEMUS DEL REY JUAN ANTONIO. Nombramientos. Secretario: SAEZ GARCIA LUIS. Datosregistrales. T 4586 , F 120, S 8, H SE 72144, I/A 6 (12.05.09).
26 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: VILLAR ALVAREZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 4586 , F 120, S 8, H SE 72144, I/A 5 ( 5.03.09).