Actos BORME de Survitec Safety Solutions Spain Sl
11 de Abril de 2023Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: SUKETU KISHOR DEVANI;JOHAN ALFONS MARIA DENIS;ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL.Nombramientos. ADM.UNICO: ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 46727 , F 117, S 8, H B 280684, I/A 19(29.03.23).
09 de Diciembre de 2022Revocaciones. APOD.MANCOMU: JOHAN ALFONS MARIA DENIS. Nombramientos. APOD.MANCOMU: ROMERO SANCHEZMONTSERRAT. Datos registrales. T 46727 , F 117, S 8, H B 280684, I/A 18 (29.11.22).
22 de Julio de 2022Revocaciones. APOD.MANCOMU: DOMINGUEZ TORRES SARA;JOHAN AHONS MARIA DENIS. Datos registrales. T 46727 , F117, S 8, H B 280684, I/A 17 (14.07.22).
20 de Enero de 2022Nombramientos. APOD.MANCOMU: CASALS MOGAS EULALIA;DOMINGUEZ TORRES SARA. Modificaci贸n de poderes.APOD.MANCOMU: BELTRAN FERRERES MIREIA;JOHAN ALFONS MARIA DENIS;ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 46727 , F 116, S 8, H B 280684, I/A 16 (12.01.22).
22 de Diciembre de 2021Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 46727 , F 116, S 8, H B280684, I/A 15 (13.12.21).
10 de Agosto de 2021Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: SUKETU KISHOR DEVANI;JOHAN ALFONS MARIA DENIS;ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL.Datos registrales. T 46727 , F 116, S 8, H B 280684, I/A 14 ( 2.08.21).
02 de Marzo de 2020Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: JOHN CYRIL GEORGE STOCKER;CACERES GARCIA DAVID. Datos registrales. T 46727 , F115, S 8, H B 280684, I/A 13 (25.02.20).
16 de Enero de 2020Nombramientos. AUDIT.CUENT.: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 46727 , F 115, S 8, H B280684, I/A 12 ( 9.01.20).
05 de Marzo de 2019Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.006,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.018,00 Euros. Datos registrales. T 45575 , F 49, S 8, H B280684, I/A 11 (26.02.19).
14 de Noviembre de 2018Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CHRISTOPHER RALPH BATES. Modificaciones estatutarias. ART.13.- ESTRUCTURA DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 45575 , F 48, S 8, H B 280684, I/A 10 (31.10.18).
19 de Septiembre de 2018Revocaciones. APOD.MANCOMU: JOANNE SARAH RUGMAN;GARCIA HERRANZ INMA. Modificaci贸n de poderes.APOD.MANCOMU: BELTRAN FERRERES MIREIA;JOHAN ALFONS MARIA DENIS;ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL. Datosregistrales. T 45575 , F 48, S 8, H B 280684, I/A 9 (10.09.18).
23 de Mayo de 2018Nombramientos. APOD.MANCOMU: JOHAN ALFONS MARIA DENIS;BELTRAN FERRERES MIREIA;JOANNE SARAHRUGMAN;GARCIA HERRANZ INMA;ROMERO NEILA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 45575 , F 48, S 8, H B 280684, I/A 8(16.05.18).
23 de Noviembre de 2017Cambio de domicilio social. CL JOSE AGUSTIN GOYTISOLO NUM.33 NAVE B (HOSPITALET DE LLOBREGAT (L'). Datosregistrales. T 45575 , F 48, S 8, H B 280684, I/A 7 (15.11.17).