Actos BORME de Susanmar Sa
02 de Agosto de 2022Nombramientos. APOD.MANCOMU: JIMENEZ GOZALVEZ MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 6216 , F 172, S 8, H B 85961, I/A28 (26.07.22).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: SERRATOSA FRANSI DAVID. Datos registrales. T 6216 , F 172, S 8, H B 85961, I/A 29(26.07.22).
Nombramientos. APOD.MANCOMU: ALTES BLASI ELISENDA. Datos registrales. T 6216 , F 173, S 8, H B 85961, I/A 30(26.07.22).
03 de Febrero de 2022Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 59.258,60 Euros. Desembolsado: 59.258,60 Euros. Resultante Suscrito: 1.021.231,22 Euros.Resultante Desembolsado: 1.021.231,22 Euros. Datos registrales. T 6216 , F 172, S 8, H B 85961, I/A 27 (27.01.22).
18 de Noviembre de 2020Revocaciones. ADM.UNICO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA. Nombramientos. ADM.UNICO: MARTINEZ VIVANCOS JOSEMARIA. Datos registrales. T 6216 , F 171, S 8, H B 85961, I/A 26 (10.11.20).
13 de Septiembre de 2017Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO: SIEMPRE SEREMOS CUATRO S.L. Datosregistrales. T 6216 , F 171, S 8, H B 85961, I/A 25 ( 6.09.17).
17 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. SISTEMA RETRIBUTIVO DELORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 6216 , F 171, S 8, H B 85961, I/A 24 ( 9.12.15).
04 de Diciembre de 2015Revocaciones. ADM.UNICO: VIVANCOS BOIX NIEVES. Nombramientos. ADM.UNICO: MARTINEZ VIVANCOS JOSE MARIA.Datos registrales. T 6216 , F 171, S 8, H B 85961, I/A 23 (25.11.15).
08 de Marzo de 2013Modificaciones estatutarias. ART.10:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales.T 6216 , F 170, S 8, H B 85961, I/A 22 (28.02.13).
14 de Junio de 2011Nombramientos. ADM.UNICO: VIVANCOS BOIX NIEVES. Datos registrales. T 6216 , F 170, S 8, H B 85961, I/A 21 ( 3.06.11).