Actos BORME de Svendborg Pv Iii SL
30 de Enero de 2023Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41068 , F 112, S 8, H M 613031, I/A 13 (23.01.23).
22 de Diciembre de 2022Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 41068 , F 111, S 8, H M 613031, I/A 12 (15.12.22).
14 de Mayo de 2021Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SONNEDIX OMICRON SL. Datos registrales. T 41068 , F 111, S 8,H M 613031, I/A 11 ( 7.05.21).
26 de Abril de 2021Nombramientos. Apo.Sol.: GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE;FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 41068 , F 110, S 8, H M 613031, I/A 10 (19.04.21).
05 de Abril de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID). Datosregistrales. T 41068 , F 110, S 8, H M 613031, I/A 9 (25.03.21).
26 de Junio de 2020Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS;VILLALBA CORTES JUAN PABLO;VILLALBA CORTES JUAN PABLO.Datos registrales. T 10382, L 7663, F 37, S 8, H V 178603, I/A 7 (18.06.20).
Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 90, S 8, H V 178603, I/A 8(18.06.20).
Revocaciones. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10382, L 7663, F 90, S 8, H V 178603, I/A 9(18.06.20).