Buscador CIF Logo

Actos BORME Sybase Iberia Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Sybase Iberia Sl

Actos BORME Sybase Iberia Sl - B80506629

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Sybase Iberia Sl con CIF B80506629

馃敊 Perfil de Sybase Iberia Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Sybase Iberia Sl

11 de Abril de 2023
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: ARVEILLER LAURENT GUILLAUME. Nombramientos. Adm. Mancom.: MACCIARDI LETICIAALEJANDRA. Datos registrales. T 16037 , F 208, S 8, H M 96493, I/A 50 (31.03.23).

Cambio de domicilio social. C/ TORRELAGUNA, 77. (MADRID). Datos registrales. T 16037 , F 208, S 8, H M 96493, I/A 51(31.03.23).

23 de Septiembre de 2021
Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16037 , F 204, S 8, H M 96493, I/A 46 (16.09.21).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GONZALEZ LINAJE JESUS ALFONSO. Secretario: GONZALEZ LINAJE JESUS ALFONSO.Consejero: MARQUES DA SILVA JOAO PAULO;PAPALAMPROS CHRISTOS. Presidente: MARQUES DA SILVA JOAO PAULO.Nombramientos. Adm. Mancom.: GONZALEZ LINAJE JESUS ALFONSO;ARVEILLER LAURENT GUILLAUME. Otros conceptos:Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 16037 , F205, S 8, H M 96493, I/A 47 (16.09.21).

Revocaciones. Apoderado: PEREZ ARBELO VICTOR MANUEL. Apo.Man.Soli: PEREZ ARBELO VICTOR MANUEL. Apo.Manc.:PAPALAMPROS CHRISTOS;PAPALAMPROS CHRISTOS. Apo.Man.Soli: PAPALAMPROS CHRISTOS. Apo.Sol.: PAPALAMPROSCHRISTOS. Apo.Man.Soli: PAPALAMPROS CHRISTOS. Apo.Sol.: PAPALAMPROS CHRISTOS. Nombramientos. Apo.Manc.:GARCIA CEREZO VICTOR. Apo.Sol.: SERRALTA HUERTA JOAQUIN. Datos registrales. T 16037 , F 205, S 8, H M 96493, I/A 48(16.09.21).

Otros conceptos: Revocaci贸n del auditor para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diiciembre de 2015, porconcurrir causa justa. Datos registrales. T 16037 , F 208, S 8, H M 96493, I/A 49 (16.09.21).

14 de Noviembre de 2017
Revocaciones. Apoderado: PASTOR CABALLERO CECILIA;VALERA Y MARTOS ENRIQUE;SERVICIOS GENERALES DEGESTION SA;STIEGER FRANCOIS;PAUWELS PHILIPPE;CAYRON LAURENT. Apo.Sol.: RUNECKLES KAREN;ALTITI AMINA.Apo.Man.Soli: PAUWELS PHILIPPE;CAYRON LAURENT;TIZON PRIETO GUADALUPE. Apo.Sol.: CARL DANIEL ROBERT.Apo.Manc.: BERENGUER BERENGUER JOAQUIN. Datos registrales. T 16037 , F 204, S 8, H M 96493, I/A 45 ( 3.11.17).

10 de Enero de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: WINKLER HARALD. Presidente: WINKLER HARALD. Cons.Del.Sol: WINKLER HARALD. Consejero:VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Vicesecret.: DIEZ VERGARA MAITANE;MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA. Revocaciones.Apoderado: VAN MEGEN JEROEN;WINKLER HARALD. Apo.Sol.: VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Apo.Man.Soli: WINKLERHARALD;VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Apo.Sol.: WINKLER HARALD;VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Apo.Man.Soli: WINKLERHARALD. Apo.Sol.: WINKLER HARALD;VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Nombramientos. Consejero: MARQUES DA SILVA JOAOPAULO;PAPALAMPROS CHRISTOS. Presidente: MARQUES DA SILVA JOAO PAULO. Apo.Manc.: PAPALAMPROSCHRISTOS;PAPALAMPROS CHRISTOS;GUERRA MOYA ELVIRA;MARQUES DA SILVA JOAO PAULO;FREIRE BARROSO ANAISABEL. Datos registrales. T 16037 , F 202, S 8, H M 96493, I/A 42 (27.12.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAPALAMPROS CHRISTOS;MARQUES DA SILVA JOAO PAULO. Apo.Sol.: PAPALAMPROSCHRISTOS;MARQUES DA SILVA JOAO PAULO. Datos registrales. T 16037 , F 203, S 8, H M 96493, I/A 43 (27.12.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAPALAMPROS CHRISTOS;MARQUES DA SILVA JOAO PAULO. Apo.Sol.: PAPALAMPROSCHRISTOS;MARQUES DA SILVA JOAO PAULO. Datos registrales. T 16037 , F 204, S 8, H M 96493, I/A 44 (27.12.13).

06 de Julio de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: CARL DANIEL ROBERT. Secretario: CARL DANIEL ROBERT. Cons.Del.Sol: CARL DANIELROBERT. Revocaciones. Apo.Sol.: CARL DANIEL ROBERT. Nombramientos. Consejero: GONZALEZ LINAJE JESUS ALFONSO.Secretario: GONZALEZ LINAJE JESUS ALFONSO. Datos registrales. T 16037 , F 202, S 8, H M 96493, I/A 41 (26.06.12).

03 de Enero de 2012
Ampliacion del objeto social. TODAS LAS OPERACIONES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE SERVICIOS DE CUALQUIERTIPO RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE LA INFORMATICA Y DE LAS COMUNICACIONES. Datos registrales. T 16037 , F201, S 8, H M 96493, I/A 40 (22.12.11).

20 de Diciembre de 2011
Nombramientos. Apo.Man.Soli: WINKLER HARALD;VAN MEGEN BRUNO JEROEN;PAUWELS PHILIPPE. Apo.Sol.: WINKLERHARALD;VAN MEGEN BRUNO JEROEN;CARL DANIEL ROBERT. Datos registrales. T 16037 , F 200, S 8, H M 96493, I/A 38 (5.12.11).

Revocaciones. Apoderado: BOWDEN TERENCE R;THOMSON LISA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: PEREZ ARBELO VICTORMANUEL;WINKLER HARALD;CAYRON LAURENT;TIZON PRIETO GUADALUPE.Apo.Sol.: WINKLER HARALD;VAN MEGENBRUNO JEROEN;CARL DANIEL ROBERT. Apo.Manc.: BERENGUER BERENGUER JOAQUIN. Otros conceptos: SE REVOCA LAFACULTAD CONTENIDA EN EL APARTADO f) DE LA ESCRITURA QUE CAUSO LA INS. 25& DE ESTA HOJA, A DON VICTORMANUEL PEREZ ARBELO, DON HARALD WINKLER y DON LAURENT CAYRON. Datos registrales. T 16037 , F 200, S 8, H M96493, I/A 39 ( 5.12.11).

17 de Octubre de 2011
Revocaciones. Apoderado: ASENSIO SANCHEZ JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 16037 , F 199, S 8, H M 96493, I/A 36(30.09.11).

Revocaciones. Apoderado: FRESNEL ELODIE. Nombramientos. Apo.Sol.: ALTITI AMINA. Datos registrales. T 16037 , F 199, S8, H M 96493, I/A 37 ( 3.10.11).

01 de Junio de 2011
Ceses/Dimisiones. Auditor: ABANTE AUDIT AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: ABANTE AUDIT AUDITORES SLP. Nombramientos.Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 16037 , F 199, S 8, H M 96493, I/A 35 (20.05.11).

24 de Mayo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: BZIUK MARCO OLIVIER. Revocaciones. Apo.Sol.: KITCHNER GLEN DEREK. Nombramientos.Consejero: VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Apo.Sol.: VAN MEGEN BRUNO JEROEN. Datos registrales. T 16037 , F 198, S 8, H M96493, I/A 34 (12.05.10).

28 de Abril de 2010
Nombramientos. Auditor: ABANTE AUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16037 , F 198, S 8, H M 96493, I/A 32 (16.04.10).

Nombramientos. Aud.C.Con.: ABANTE AUDIT AUDITORES SLP. Datos registrales. T 16037 , F 198, S 8, H M 96493, I/A 33(16.04.10).

25 de Junio de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: VAN DER VORST PIETER. Presidente: VAN DER VORST PIETER. Cons.Del.Sol: VAN DER VORSTPIETER. Nombramientos. Presidente: WINKLER HARALD. Cons.Del.Sol: WINKLER HARALD. Datos registrales. T 16037 , F 197,S 8, H M 96493, I/A 31 (15.06.09).

09 de Febrero de 2009
Nombramientos. Apo.Sol.: RUNECKLES KAREN;KITCHNER GLEN DEREK. Datos registrales. T 16037 , F 197, S 8, H M 96493,I/A 30 (28.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n