Buscador CIF Logo

Actos BORME Syddjurs I Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Syddjurs I Sl

Actos BORME Syddjurs I Sl - B25666033

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Syddjurs I Sl con CIF B25666033

馃敊 Perfil de Syddjurs I Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Syddjurs I Sl

30 de Enero de 2023
Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T 41684 , F 117, S 8, H M 738407, I/A 5 (23.01.23).

22 de Diciembre de 2022
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Adm. Unico: SONNEDIX ESPA脩A SOCIEDAD LIMITADA. Representan: GARCIA MASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Datos registrales.T 41684 , F 117, S 8, H M 738407, I/A 4 (15.12.22).

04 de Mayo de 2021
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ HERNANDEZ GERSON JOSE;FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL. Datosregistrales. T 41684 , F 115, S 8, H M 738407, I/A 3 (26.04.21).

05 de Abril de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: NORMANN MARC. Nombramientos. Adm. Unico: SONNEDIX ZETA SL. Representan: GARCIAMASCU脩AN MIGUEL ANGEL. Cambio de domicilio social. C/ PRINCIPE DE VERGARA 108, PLANTA 12 (MADRID). Datosregistrales. T 41684 , F 115, S 8, H M 738407, I/A 2 (25.03.21).

26 de Junio de 2020
Revocaciones. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10402, L 7683, F 54, S 8, H V 179078, I/A 7(18.06.20).

Revocaciones. Apo.Sol.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 10402, L 7683, F 54, S 8, H V 179078, I/A 8(18.06.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Apo.Man.Soli: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Datos registrales. T10402, L 7683, F 54, S 8, H V 179078, I/A 9 (18.06.20).

18 de Mayo de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GAARN-LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: NORMANN MARC. Datosregistrales. T 10402, L 7683, F 53, S 8, H V 179078, I/A 6 ( 8.05.20).

07 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10402, L 7683, F 53, S 8, H V 179078, I/A 5 (30.10.18).

05 de Noviembre de 2018
Revocaciones. Apoderado: KARTES TILLMANN. Apo.Sol.: WICKE RICHARD. Datos registrales. T 10402, L 7683, F 53, S 8, H V179078, I/A 3 (26.10.18).

Revocaciones. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 10402, L 7683, F 53, S 8, H V 179078, I/A 4(26.10.18).

15 de Diciembre de 2017
Cambio de domicilio social. PLAZA ALQUERIA DE LA CULLA 4 - OFI9CINA 355 (ALFAFAR). Datos registrales. T 10402, L 7683,F 53, S 8, H V 179078, I/A 2 ( 7.12.17).

12 de Julio de 2017
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA. Datos registrales. T 1142 , F 196, S 8, H L 22682, I/A 14 ( 3.07.17).

10 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1142 , F 196, S 8, H L 22682, I/A 13 ( 3.03.17).

07 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Sol.: VILLALBA CORTES JUAN PABLO. Apo.Manc.: WICKERICHARD;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1142 , F 195, S 8, H L 22682, I/A 12 (28.02.17).

28 de Junio de 2016
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN LARSEN LARS CHRISTIAN. Nombramientos. Adm. Unico: GAARNLARSEN LARS CHRISTIAN. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios a Administrador煤nico. Datos registrales. T 1142 , F 195, S 8, H L 22682, I/A 11 (16.06.16).

15 de Julio de 2015
Revocaciones. Apo.Sol.: SORIA SORJUS JOSE;YOSHIDA NATALIE;MESTRE BONCOMPTE BLANCA;CAJA RUIZ I脩IGO. Datosregistrales. T 1142 , F 194, S 8, H L 22682, I/A 8 ( 1.07.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ CHAVES JOSE MARIA;GANDIA FORNES JOSE LUIS. Datos registrales. T 1142 , F 194,S 8, H L 22682, I/A 9 ( 3.07.15).

Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMAN KLAUS WILLY. Datos registrales. T 1142 , F 195, S 8, H L 22682,I/A 10 ( 7.07.15).

01 de Agosto de 2014
Nombramientos. Apo.Sol.: WICKE RICHARD;KARTES TILLMANN. Datos registrales. T 1142 , F 193, S 8, H L 22682, I/A 6(21.07.14).

Nombramientos. Apoderado: NEXUS ENERGIA SA;NEXUS ENERGIA SA. Datos registrales. T 1142 , F 193, S 8, H L 22682, I/A 7(21.07.14).

22 de Noviembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: TOMESA GESTION SL. Nombramientos. Adm. Solid.: LIEBEL CHRISTIAN;GAARN LARSENLARS CHRISTIAN. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico a Administradoressolidarios. Datos registrales. T 1142 , F 192, S 8, H L 22682, I/A 5 (13.11.12).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n