Actos BORME de Symbol Technologies Sl
23 de Diciembre de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LOPEZ ROSAS MIGUEL ANGEL;TORRES SANCHEZ MANUEL. Presidente: TORRES SANCHEZMANUEL. Consejero: WOZNIAK JOHN KENNETH. Secretario: LLANEZA ALONSO GRACIELA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n.Datos registrales. T 3942 , F 223, S 8, H M 28253, I/A 47 (10.12.10).
03 de Agosto de 2010Cambio de domicilio social. C/ MARTINEZ VILLERGAS 52 - BLOQUE C (MADRID). Datos registrales. T 3942 , F 222, S 8, H M28253, I/A 46 (22.07.10).
15 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: FITZPATRICK EDWARD. Nombramientos. Consejero: WOZNIAK JOHN KENNETH. Datosregistrales. T 3942 , F 222, S 8, H M 28253, I/A 45 ( 6.07.10).
24 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: MEISSNER LAUREL GRACE. Presidente: LOPEZ ROSAS MIGUEL ANGEL. Nombramientos.Consejero: FITZPATRICK EDWARD. Presidente: TORRES SANCHEZ MANUEL. Datos registrales. T 3942 , F 220, S 8, H M 28253,I/A 43 (14.07.09).
Nombramientos. Apoderado: TORRES SANCHEZ MANUEL;LOPEZ ROSAS MIGUEL ANGEL;VALLE ALVAREZ INES;LARRY R.RAYMOND;ROWICKI PERRY. Datos registrales. T 3942 , F 220, S 8, H M 28253, I/A 44 (14.07.09).
30 de Junio de 2009Articulo 378.5 del Reglamento del Registro Mercantil. Justificacion de no aprobacion de cuentas del ejercicio 2007 mediante
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: SYMBOL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL INC. P茅rdida del caracter deunipersonalidad. Nombramientos. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 3942 , F 220, S 8, H M 28253, I/A 42(18.06.09).
19 de Junio de 2009Ceses/Dimisiones. Presidente: ROCHE IAN MARTIN. Consejero: ROCHE IAN MARTIN;PORRETTO JAMES;ABBOTT TODDALAN;BURTON JAN HARDER. Secretario: DE LIZARZA INDA FRANCISCO JAVIER. Consejero: DE LIZARZA INDA FRANCISCOJAVIER;LANGROCK JAMES. Nombramientos. SecreNoConsj: LLANEZA ALONSO GRACIELA. Consejero: LOPEZ ROSASMIGUEL ANGEL. Presidente: LOPEZ ROSAS MIGUEL ANGEL. Consejero: TORRES SANCHEZ MANUEL;MEISSNER LAURELGRACE. Datos registrales. T 3942 , F 219, S 8, H M 28253, I/A 40 ( 8.06.09).