Buscador CIF Logo

Actos BORME Tafamus Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tafamus Sl

Actos BORME Tafamus Sl - B84092626

Tenemos registrados 26 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tafamus Sl con CIF B84092626

馃敊 Perfil de Tafamus Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tafamus Sl

06 de Abril de 2021
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33067 , F 214, S 8, H M362093, I/A 37 (26.03.21).

04 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RAMOS DIEGO;FERNANDEZ RAMOS VICTOR. Datos registrales. T 33067 , F 108, S 8,H M 362093, I/A 35 (24.04.18).

Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Apo.Sol.: LOPEZ HERMIDAFERNANDO. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO;LOPEZ HERMIDA FERNANDO;GONZALEZ MARQUEZ SERGIO;MELEROLLERA PABLO-JOSE. Datos registrales. T 33067 , F 214, S 8, H M 362093, I/A 36 (24.04.18).

30 de Abril de 2018
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Datos registrales. T 33067 , F 107, S 8, H M 362093, I/A 34(20.04.18).

12 de Junio de 2017
Nombramientos. Apoderado: BRACAMONTE MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 33067 , F 105, S 8, H M 362093, I/A33 ( 5.06.17).

15 de Marzo de 2017
Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RAMOS DIEGO;FERNANDEZ RAMOS VICTOR. Datos registrales. T 33067 , F 103, S8, H M 362093, I/A 32 ( 7.03.17).

27 de Febrero de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.210.385,00 Euros. Datos registrales. T 33067 , F 103, S 8,H M 362093, I/A 31 (17.02.17).

23 de Febrero de 2017
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ANABEL BV. Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MAZORRABELARMINO;PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL;MIDESLONIA ADMINISTRACION SL.Presidente: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Consejero: FLENOX SL. Vicepresid.: PARTILONIA ADMINISTRACION SL.Secretario: MIGUEL-ROMERO DE OLANO IGNACIO. Representan: ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID;MANOTAS CABEZA ANGEL;DERIVERA GARCIA DE LEANIZ GONZALO;DE RIVERA GARCIA DE LEANIZ GONZALO. Nombramientos. Adm. Unico: RAMOSMARQUES DE OLIVEIRA ANA LUCIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M 362093, I/A 30 (16.02.17).

05 de Agosto de 2016
Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M362093, I/A 29 (29.07.16).

28 de Julio de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPI MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M 362093, I/A 28(19.07.16).

13 de Abril de 2016
Nombramientos. Apoderado: MELERO LLERA PABLO-JOSE. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 27 (5.04.16).

15 de Febrero de 2016
Ceses/Dimisiones. Representan: LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Representan: DE RIVERA GARCIA DE LEANIZGONZALO. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 25 ( 4.02.16).

Ceses/Dimisiones. Representan: LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Representan: DE RIVERA GARCIA DE LEANIZGONZALO. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 26 ( 4.02.16).

05 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL. Nombramientos. Vicepresid.: PARTILONIAADMINISTRACION SL. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 24 (29.01.15).

04 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Representan: BARALLOBRE GORDON CARLOS. Nombramientos. Representan: MANOTAS CABEZAANGEL. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 23 (28.01.15).

09 de Abril de 2014
Ceses/Dimisiones. Representan: ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID. Nombramientos. Representan: BARALLOBRE GORDONCARLOS. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 22 (31.03.14).

28 de Enero de 2014
Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL.Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 21 (20.01.14).

17 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Representan: MATE RODRIGUEZ RAFAEL. Consejero: MERCAPITAL SL. Nombramientos. Representan:LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Consejero: FLENOX SL. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 20 (10.12.13).

22 de Noviembre de 2012
Cambio de objeto social. LA COMPRA, SUSCRIPCION, PERMUTA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS,NACIONALES Y EXTRANJEROS... Datos registrales. T 27655 , F 167, S 8, H M 362093, I/A 19 (12.11.12).

21 de Septiembre de 2012
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO;GONZALEZ MARQUEZ SERGIO. Datos registrales. T 27655 , F 165,S 8, H M 362093, I/A 18 (11.09.12).

20 de Septiembre de 2012
P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ MAZORRA BERLARMINO;FERNANDEZIGLESIAS BELARMINO. Nombramientos. Secretario: MIGUEL-ROMERO DE OLANO IGNACIO. Representan: LOIZAGA JIMENEZJAVIER;ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID;ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID. Consejero: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO;ESPIMARTINEZ JOSE MARIA;PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL;MIDESLONIAADMINISTRACION SL;MERCAPITAL SL. Presidente: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Vicepresid.: PAULONIA SERVICIOSDE GESTION SL. Representan: MATE RODRIGUEZ RAFAEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.135.002,00 Euros. ResultanteSuscrito: 4.310.385,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aConsejo de administraci贸n. Otros conceptos: SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 27655 , F 158, S 8, H M 362093, I/A 17 (10.09.12).

03 de Mayo de 2012
Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.384.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.175.383,00 Euros. Datos registrales. T 27655 , F 158, S8, H M 362093, I/A 16 (17.04.12).

20 de Marzo de 2012
Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27655 , F 158, S 8, H M 362093, I/A 15 ( 7.03.12).

15 de Junio de 2010
Cambio de domicilio social. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 37 (MADRID). Datos registrales. T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A 13(31.05.10).

Nombramientos. Apoderado: MARQUES DE OLIVEIRA IGLESIAS ANA LUCIA;LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Datos registrales.T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A 14 (31.05.10).

31 de Mayo de 2010
Nombramientos. Auditor: SANCHEZ-DE-ROJAS PANFIL JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A12 (19.05.10).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n