Actos BORME de Tafamus Sl
06 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33067 , F 214, S 8, H M362093, I/A 37 (26.03.21).
04 de Mayo de 2018Nombramientos. Apo.Sol.: FERNANDEZ RAMOS DIEGO;FERNANDEZ RAMOS VICTOR. Datos registrales. T 33067 , F 108, S 8,H M 362093, I/A 35 (24.04.18).
Revocaciones. Apo.Manc.: LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Apo.Sol.: LOPEZ HERMIDAFERNANDO. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO;LOPEZ HERMIDA FERNANDO;GONZALEZ MARQUEZ SERGIO;MELEROLLERA PABLO-JOSE. Datos registrales. T 33067 , F 214, S 8, H M 362093, I/A 36 (24.04.18).
30 de Abril de 2018Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Datos registrales. T 33067 , F 107, S 8, H M 362093, I/A 34(20.04.18).
12 de Junio de 2017Nombramientos. Apoderado: BRACAMONTE MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 33067 , F 105, S 8, H M 362093, I/A33 ( 5.06.17).
15 de Marzo de 2017Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ RAMOS DIEGO;FERNANDEZ RAMOS VICTOR. Datos registrales. T 33067 , F 103, S8, H M 362093, I/A 32 ( 7.03.17).
27 de Febrero de 2017Ampliaci贸n de capital. Capital: 900.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 5.210.385,00 Euros. Datos registrales. T 33067 , F 103, S 8,H M 362093, I/A 31 (17.02.17).
23 de Febrero de 2017Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: ANABEL BV. Ceses/Dimisiones. Consejero: FERNANDEZ MAZORRABELARMINO;PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL;MIDESLONIA ADMINISTRACION SL.Presidente: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Consejero: FLENOX SL. Vicepresid.: PARTILONIA ADMINISTRACION SL.Secretario: MIGUEL-ROMERO DE OLANO IGNACIO. Representan: ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID;MANOTAS CABEZA ANGEL;DERIVERA GARCIA DE LEANIZ GONZALO;DE RIVERA GARCIA DE LEANIZ GONZALO. Nombramientos. Adm. Unico: RAMOSMARQUES DE OLIVEIRA ANA LUCIA. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Consejo de administraci贸n aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M 362093, I/A 30 (16.02.17).
05 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M362093, I/A 29 (29.07.16).
28 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPI MARTINEZ JOSE MARIA. Datos registrales. T 33067 , F 102, S 8, H M 362093, I/A 28(19.07.16).
13 de Abril de 2016Nombramientos. Apoderado: MELERO LLERA PABLO-JOSE. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 27 (5.04.16).
15 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Representan: LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Representan: DE RIVERA GARCIA DE LEANIZGONZALO. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 25 ( 4.02.16).
Ceses/Dimisiones. Representan: LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Nombramientos. Representan: DE RIVERA GARCIA DE LEANIZGONZALO. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 26 ( 4.02.16).
05 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL. Nombramientos. Vicepresid.: PARTILONIAADMINISTRACION SL. Datos registrales. T 33067 , F 100, S 8, H M 362093, I/A 24 (29.01.15).
04 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Representan: BARALLOBRE GORDON CARLOS. Nombramientos. Representan: MANOTAS CABEZAANGEL. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 23 (28.01.15).
09 de Abril de 2014Ceses/Dimisiones. Representan: ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID. Nombramientos. Representan: BARALLOBRE GORDONCARLOS. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 22 (31.03.14).
28 de Enero de 2014Revocaciones. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Aud.C.Con.: BDO AUDITORES SL.Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 21 (20.01.14).
17 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Representan: MATE RODRIGUEZ RAFAEL. Consejero: MERCAPITAL SL. Nombramientos. Representan:LOIZAGA JIMENEZ JAVIER. Consejero: FLENOX SL. Datos registrales. T 27655 , F 168, S 8, H M 362093, I/A 20 (10.12.13).
22 de Noviembre de 2012Cambio de objeto social. LA COMPRA, SUSCRIPCION, PERMUTA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS,NACIONALES Y EXTRANJEROS... Datos registrales. T 27655 , F 167, S 8, H M 362093, I/A 19 (12.11.12).
21 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apoderado: LOPEZ HERMIDA FERNANDO;GONZALEZ MARQUEZ SERGIO. Datos registrales. T 27655 , F 165,S 8, H M 362093, I/A 18 (11.09.12).
20 de Septiembre de 2012P茅rdida del caracter de unipersonalidad. Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: FERNANDEZ MAZORRA BERLARMINO;FERNANDEZIGLESIAS BELARMINO. Nombramientos. Secretario: MIGUEL-ROMERO DE OLANO IGNACIO. Representan: LOIZAGA JIMENEZJAVIER;ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID;ESTEFANELL PA脩ELLA DAVID. Consejero: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO;ESPIMARTINEZ JOSE MARIA;PAULONIA SERVICIOS DE GESTION SL;PARTILONIA ADMINISTRACION SL;MIDESLONIAADMINISTRACION SL;MERCAPITAL SL. Presidente: FERNANDEZ MAZORRA BELARMINO. Vicepresid.: PAULONIA SERVICIOSDE GESTION SL. Representan: MATE RODRIGUEZ RAFAEL. Ampliaci贸n de capital. Capital: 2.135.002,00 Euros. ResultanteSuscrito: 4.310.385,00 Euros. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aConsejo de administraci贸n. Otros conceptos: SE APRUEBA UN NUEVO TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.Datos registrales. T 27655 , F 158, S 8, H M 362093, I/A 17 (10.09.12).
03 de Mayo de 2012Ampliaci贸n de capital. Capital: 1.384.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 2.175.383,00 Euros. Datos registrales. T 27655 , F 158, S8, H M 362093, I/A 16 (17.04.12).
20 de Marzo de 2012Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 27655 , F 158, S 8, H M 362093, I/A 15 ( 7.03.12).
15 de Junio de 2010Cambio de domicilio social. C/ JUAN RAMON JIMENEZ 37 (MADRID). Datos registrales. T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A 13(31.05.10).
Nombramientos. Apoderado: MARQUES DE OLIVEIRA IGLESIAS ANA LUCIA;LOPEZ HERMIDA FERNANDO. Datos registrales.T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A 14 (31.05.10).
31 de Mayo de 2010Nombramientos. Auditor: SANCHEZ-DE-ROJAS PANFIL JOSE-ANTONIO. Datos registrales. T 20467 , F 80, S 8, H M 362093, I/A12 (19.05.10).