Actos BORME de Talleres Silvoso Sl
04 de Octubre de 2018Revocaciones. Apoderado: MEIS GIRALDEZ ANTONIO-JAVIER. Datos registrales. T 531, L 531, F 186, S 8, H PO 8338, I/A 16(26.09.18).
03 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: MEIS GIRALDEZ ANTONIO-JAVIER. Datos registrales. T 531, L 531, F 185, S 8, H PO 8338, I/A 15(20.04.18).
05 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: MEIS GIRALDEZ ANTONIO-JAVIER. Datos registrales. T 531, L 531, F 184, S 8, H PO 8338, I/A 14(28.01.16).
01 de Octubre de 2015Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ PADIN MARTA. Datos registrales. T 531, L 531, F 183, S 8, H PO 8338, I/A 12(23.09.15).
Nombramientos. Apoderado: SILVOSO DE LA MAZA JUAN. Datos registrales. T 531, L 531, F 183, S 8, H PO 8338, I/A 13(23.09.15).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ PADIN MARTA. Datos registrales. T 531, L 531, F 182, S 8, H PO 8338, I/A 11(14.05.13).
26 de Febrero de 2009Revocaciones. Apoderado: RODRIGUEZ FEIJOO RAMON. Datos registrales. T 531, L 531, F 182, S 8, H PO 8338, I/A 10(13.02.09).