Buscador CIF Logo

Actos BORME Tarnos Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tarnos Sa

Actos BORME Tarnos Sa - A28101665

Tenemos registrados 24 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tarnos Sa con CIF A28101665

馃敊 Perfil de Tarnos Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tarnos Sa

02 de Octubre de 2023
Ceses/Dimisiones. Consejero: NORIEGA BASTOS MANUEL. Nombramientos. Consejero: NORIEGA DE LA MAZASANTIAGO;NORIEGA PICARDO RICARDO. Datos registrales. T 26197 , F 57, S 8, H M 9286, I/A 44 (25.09.23).

05 de Junio de 2023
Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 57, S 8, H M 9286, I/A 43(29.05.23).

05 de Agosto de 2022
Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 26197 , F56, S 8, H M 9286, I/A 42 (29.07.22).

01 de Junio de 2022
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Datos registrales. T 26197 , F 56, S 8, H M 9286, I/A 41(25.05.22).

20 de Noviembre de 2020
Modificaciones estatutarias. Incorporaci贸n del art铆culo 15 bis y 20 bis de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 26197 , F 56,S 8, H M 9286, I/A 40 (13.11.20).

05 de Octubre de 2020
Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 56, S 8, H M 9286, I/A 39(28.09.20).

31 de Mayo de 2019
Reelecciones. Consejero: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDONORIEGA IGNACIO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGA JAIME;DE LACALLENORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Presidente:NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 38 (24.05.19).

03 de Septiembre de 2018
Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 37 (27.08.18).

17 de Mayo de 2018
Nombramientos. Apoderado: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 36 ( 8.05.18).

23 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: TEJADA VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 35 (16.04.18).

19 de Abril de 2018
Revocaciones. Apoderado: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 34 (12.04.18).

04 de Julio de 2017
Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 33(26.06.17).

16 de Noviembre de 2015
Nombramientos. Apoderado: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 32 ( 5.11.15).

13 de Julio de 2015
Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TARNOS VIBRACION SL. TARNOS FILTRACION SL. Datos registrales. T 26197 ,F 49, S 8, H M 9286, I/A 31 ( 3.07.15).

16 de Octubre de 2014
Nombramientos. Consejero: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO.Consejero: HORNEDO NORIEGA IGNACIO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGAJAIME;DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGAGONZALO. Presidente: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 26197 , F 49, S 8, H M 9286, I/A 30 ( 8.10.14).

15 de Septiembre de 2014
Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 48, S 8, H M 9286, I/A 29(26.08.14).

30 de Mayo de 2014
Revocaciones. Apoderado: MENDEZ URE脩A FRANCISCO PAULA. Datos registrales. T 26197 , F 47, S 8, H M 9286, I/A 28(23.05.14).

19 de Febrero de 2014
Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 26& EL NOMBRAMIENTO DE GOMEZ PALLETE FERNANDOCOMO CONSEJERO, SIENDO LO CORRECTO GOMEZ PALLETE RIVAS FERNANDO. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M9286, I/A 26 (16.08.12).

Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ PALLETE RIVAS FERNANDO. Datos registrales. T 26197 , F 47, S 8, H M 9286, I/A 27(12.02.14).

19 de Septiembre de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Presidente: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Nombramientos.Presidente: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDONORIEGA IGNACIO;GOMEZ PALLETE FERNANDO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLENORIEGA JAIME;DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLENORIEGA GONZALO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.920,67 Euros. Resultante Suscrito: 54.279,33 Euros. Ampliaci贸nde capital. Suscrito: 5.920,67 Euros. Desembolsado: 5.920,67 Euros. Resultante Suscrito: 60.200,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 60.200,00 Euros. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M 9286, I/A 26 (16.08.12).

27 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M 9286, I/A 25(17.01.12).

18 de Abril de 2011
Nombramientos. Apoderado: TEJADA VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 26197 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 24 ( 5.04.11).

19 de Agosto de 2010
Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDO NORIEGA IGNACIO;GOMEZ PALLETEFERNANDO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGA JAIME;DE LACALLE NORIEGAGONZALO;NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Presidente: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO.Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Datos registrales. T 26197 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 23 ( 5.08.10).

20 de Enero de 2009
Nombramientos. Auditor: VELAUDIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 485 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 22 ( 8.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n