Actos BORME de Tarnos Sa
02 de Octubre de 2023Ceses/Dimisiones. Consejero: NORIEGA BASTOS MANUEL. Nombramientos. Consejero: NORIEGA DE LA MAZASANTIAGO;NORIEGA PICARDO RICARDO. Datos registrales. T 26197 , F 57, S 8, H M 9286, I/A 44 (25.09.23).
05 de Junio de 2023Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 57, S 8, H M 9286, I/A 43(29.05.23).
05 de Agosto de 2022Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 26197 , F56, S 8, H M 9286, I/A 42 (29.07.22).
01 de Junio de 2022Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Datos registrales. T 26197 , F 56, S 8, H M 9286, I/A 41(25.05.22).
20 de Noviembre de 2020Modificaciones estatutarias. Incorporaci贸n del art铆culo 15 bis y 20 bis de los estatutos sociales.. Datos registrales. T 26197 , F 56,S 8, H M 9286, I/A 40 (13.11.20).
05 de Octubre de 2020Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 56, S 8, H M 9286, I/A 39(28.09.20).
31 de Mayo de 2019Reelecciones. Consejero: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDONORIEGA IGNACIO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGA JAIME;DE LACALLENORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Presidente:NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 38 (24.05.19).
03 de Septiembre de 2018Nombramientos. Apoderado: SANCHEZ PEREZ ANA MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 37 (27.08.18).
17 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Datos registrales. T 26197 , F 55, S 8, H M 9286, I/A 36 ( 8.05.18).
23 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: TEJADA VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 35 (16.04.18).
19 de Abril de 2018Revocaciones. Apoderado: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 34 (12.04.18).
04 de Julio de 2017Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 33(26.06.17).
16 de Noviembre de 2015Nombramientos. Apoderado: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Datos registrales. T 26197 , F 54, S 8, H M 9286, I/A 32 ( 5.11.15).
13 de Julio de 2015Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TARNOS VIBRACION SL. TARNOS FILTRACION SL. Datos registrales. T 26197 ,F 49, S 8, H M 9286, I/A 31 ( 3.07.15).
16 de Octubre de 2014Nombramientos. Consejero: EPALZA SOLANO JOSE MARIA. Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO.Consejero: HORNEDO NORIEGA IGNACIO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGAJAIME;DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGAGONZALO. Presidente: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Modificaciones estatutarias. SE MODIFICA EL ARTICULO 17潞 DE LOSESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 26197 , F 49, S 8, H M 9286, I/A 30 ( 8.10.14).
15 de Septiembre de 2014Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 48, S 8, H M 9286, I/A 29(26.08.14).
30 de Mayo de 2014Revocaciones. Apoderado: MENDEZ URE脩A FRANCISCO PAULA. Datos registrales. T 26197 , F 47, S 8, H M 9286, I/A 28(23.05.14).
19 de Febrero de 2014Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 26& EL NOMBRAMIENTO DE GOMEZ PALLETE FERNANDOCOMO CONSEJERO, SIENDO LO CORRECTO GOMEZ PALLETE RIVAS FERNANDO. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M9286, I/A 26 (16.08.12).
Ceses/Dimisiones. Consejero: GOMEZ PALLETE RIVAS FERNANDO. Datos registrales. T 26197 , F 47, S 8, H M 9286, I/A 27(12.02.14).
19 de Septiembre de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Presidente: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Nombramientos.Presidente: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDONORIEGA IGNACIO;GOMEZ PALLETE FERNANDO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLENORIEGA JAIME;DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO. Vicepresid.: DE LACALLENORIEGA GONZALO. Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.920,67 Euros. Resultante Suscrito: 54.279,33 Euros. Ampliaci贸nde capital. Suscrito: 5.920,67 Euros. Desembolsado: 5.920,67 Euros. Resultante Suscrito: 60.200,00 Euros. ResultanteDesembolsado: 60.200,00 Euros. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M 9286, I/A 26 (16.08.12).
27 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: ESPAUDIT GABINETE DE AUDITORIA SAP. Datos registrales. T 26197 , F 46, S 8, H M 9286, I/A 25(17.01.12).
18 de Abril de 2011Nombramientos. Apoderado: TEJADA VAZQUEZ RAFAEL. Datos registrales. T 26197 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 24 ( 5.04.11).
19 de Agosto de 2010Reelecciones. Secretario: HORNEDO NORIEGA IGNACIO. Consejero: HORNEDO NORIEGA IGNACIO;GOMEZ PALLETEFERNANDO;NORIEGA BASTOS MANUEL;NORIEGA BASTOS SANTIAGO;DE LACALLE NORIEGA JAIME;DE LACALLE NORIEGAGONZALO;NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Presidente: NORIEGA RUIZ FLORENCIO. Con.Delegado: NORIEGA BASTOS SANTIAGO.Vicepresid.: DE LACALLE NORIEGA GONZALO. Datos registrales. T 26197 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 23 ( 5.08.10).
20 de Enero de 2009Nombramientos. Auditor: VELAUDIA AUDITORES SL. Datos registrales. T 485 , F 45, S 8, H M 9286, I/A 22 ( 8.01.09).