Actos BORME de Tartiere Auto Sl
02 de Noviembre de 2023Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 7.09.23. Objeto social: la exposici贸n, explotaci贸n y venta como concesionaria de veh铆culosautom贸viles, maquinaria de toda clase de veh铆culos a motor, compra, venta y reparaci贸n de veh铆culos autom贸viles nuevos y usados,repuestos, accesorios y toda clase de materiales relacionados con la industria del autom贸vil, veh铆culos. Domicilio: CTRA DE GIJONS/N (SIERO). Capital: 275.000,00 Euros. Nombramientos. SecreNoConsj: TARTIERE GOYENECHEA INES. Consejero: TARTIEREGOYENECHEA VICTOR;SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;RENTING SHARE SL. Presidente: TARTIERE GOYENECHEA VICTOR.Vicepresid.: SALAZAR PE脩ALBA FRANCISCO JAVIER. Con.Delegado: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA. Consejero: SALAZARPE脩ALBA FRANCISCO JAVIER;FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ JESUS MARIA. Datos registrales. T 4569 , F 6, S 8, H AS61385, I/A 1 (25.10.23).
Escisi贸n total. Sociedades beneficiarias de la escisi贸n: TARTIERE INVERSIONES INMOBILIARIAS SL. TARTIERE MOVILIDADSL. TARTIERE AUTO SL. Disoluci贸n. Escision. Extinci贸n. Datos registrales. T 1083 , F 173, S 8, H AS 1517, I/A 42 (25.10.23).
06 de Julio de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZJAVIER.Apo.Sol.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZ JAVIER. Datosregistrales. T 1083 , F 172, S 8, H AS 1517, I/A 40 (29.06.22).
Nombramientos. Apo.Manc.: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE.Apo.Manc.: SERRADA LOPEZ JAVIER. Apo.Sol.: SERRADA LOPEZ JAVIER. Apo.Manc.: SANCHEZ ARAUJO JORGE LUIS.Apo.Sol.: SANCHEZ ARAUJO JORGE LUIS. Datos registrales. T 1083 , F 172, S 8, H AS 1517, I/A 41 (29.06.22).
21 de Enero de 2021Nombramientos. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1083 , F 172, S 8, H AS 1517, I/A39 (12.01.21).
25 de Agosto de 2020Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: FERNANDEZ-JARDON FERNANDEZ JESUS MARIA. Nombramientos. Consejero: SALAZARPE脩ALBA JOSE MARIA. Con.Delegado: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA. Datos registrales. T 1083 , F 172, S 8, H AS 1517, I/A38 (14.08.20).
21 de Agosto de 2019Nombramientos. Apo.Manc.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZJAVIER.Apo.Sol.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZ JAVIER. Datos
04 de Julio de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 3. Objeto social.-. Cambio de objeto social. CNAE 4511.- La exposici贸n,explotaci贸n y venta como concesionaria de veh铆culos autom贸viles, maquinaria de toda clase de veh铆culos a motor, compra, venta yreparaci贸n de veh铆culos autom贸viles nuevos y usados, repuestos, accesorios y toda clase de materiales relacionados con la industriadel autom贸vil. Datos registrales. T 1083 , F 157, S 8, H AS 1517, I/A 35 (27.06.19).
Revocaciones. Apoderado: CAMPORRO BRAVO ANA ISABEL;SIERRA RAIGADA JOSE. Datos registrales. T 1083 , F 157, S 8, HAS 1517, I/A 36 (27.06.19).
04 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apo.Manc.: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Apo.Sol.: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE.Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ FUEYO PABLO JOSE. Apo.Sol.: GONZALEZ FUEYO PABLO JOSE. Datos registrales. T1083 , F 157, S 8, H AS 1517, I/A 33 (23.11.18).
Nombramientos. Apo.Sol.: PELAEZ MATA PALOMA;FERNANDEZ FLOREZ MARTA. Datos registrales. T 1083 , F 157, S 8, H AS1517, I/A 34 (23.11.18).
16 de Febrero de 2018Nombramientos. Apo.Manc.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZJAVIER.Apo.Sol.: SALAZAR PE脩ALBA JOSE MARIA;FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE;SERRADA LOPEZ JAVIER. Datosregistrales. T 1083 , F 156, S 8, H AS 1517, I/A 32 ( 8.02.18).
19 de Enero de 2018Reelecciones. Auditor: MENENDEZ AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1083 , F 156, S 8, H AS 1517, I/A 31
03 de Agosto de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: COFINEX SL;SALAPE脩A SA. Vicepresid.: SALAPE脩A SA. Nombramientos. Consejero: RENTINGSHARE SL;SALAZAR PE脩ALBA FRANCISCO JAVIER. Vicepresid.: SALAZAR PE脩ALBA FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T1083 , F 156, S 8, H AS 1517, I/A 30 (26.07.17).
26 de Mayo de 2017Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: ASTUR WAGEN SL. Datos registrales. T 1083 , F 155, S 8, H AS 1517, I/A 29(17.05.17).
14 de Octubre de 2016Nombramientos. Apoderado: FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO JOSE. Datos registrales. T 1083 , F 155, S 8, H AS 1517, I/A 28( 5.10.16).