Buscador CIF Logo

Actos BORME Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa

Actos BORME Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa - A05452347

Tenemos registrados 22 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa con CIF A05452347

馃敊 Perfil de Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa

04 de Agosto de 2023
Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 16.000.000,00 Euros. Desembolsado: 16.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.000.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 24.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 42441 , F 41, S 8, H M 751074, I/A 5 (28.07.23).

26 de Agosto de 2022
Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42441 , F 41, S 8, H M 751074, I/A 4 (19.08.22).

22 de Octubre de 2021
Nombramientos. Presidente: JUANAS GARRIDO YOLANDA. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. SecreNoConsj:AGUADO FERNANDEZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 42441 , F 39, S 8, H M 751074, I/A 2 (15.10.21).

Nombramientos. Apoderado: JUANAS GARRIDO YOLANDA;FERNANDEZ SANCHEZ DEL PERAL FRANCISCO-JAVIER;LIZCANOABENGOZAR JOAQUIN;ALONSO MARTIN-LOECHES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 42441 , F 40, S 8, H M 751074, I/A 3(15.10.21).

22 de Septiembre de 2021
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.04.21. Objeto social: El desarrollo y ejecuci贸n de trabajos de mantenimiento integral detrenes del parque de veh铆culos propiedad del Grupo Renfe, mediante el mantenimiento o reparaci贸n de toda clase de elementosindustriales, electr贸nicos, el茅ctricos o mec谩nicos, incluyendo todas las tareas propias de ingenier铆a,. Domicilio: PASEO DEL TRENTALGO 2 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Capital suscrito: 8.000.000,00 Euros. Desembolsado: 8.000.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: JUANAS GARRIDO YOLANDA;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;SEGURA ECHANIZ ALVARO;LIZCANO ABENGOZARJOAQUIN;MINAYO DE LA CRUZ MIGUEL FELIX;VICENTE CALADO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 42441 , F 36, S 8, H M751074, I/A 1 (15.09.21).

27 de Diciembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLEJO ABAD SEGUNDO;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA.Presidente: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Vicepresid.: HENAR PEREZ LUIS ALFONSO. Secretario: DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA.Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T30892 , F 135, S 8, H M 473412, I/A 17 (19.12.13).

14 de Noviembre de 2013
Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PATENTES TALGO SL. Datos registrales. T 30892 , F 135, S 8, H M 473412, I/A16 ( 6.11.13).

12 de Noviembre de 2013
Ceses/Dimisiones. Secretario: SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL. Consejero: JIMENEZ REDONDO JOSEANTONIO;AZUARA SANCHEZ RAMON;GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Vicepresid.: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO.Co.De.Ma.So: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Nombramientos. Vicepresid.: HENAR PEREZLUIS ALFONSO. Secretario: DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;DOMINGUEZ ROA JULIO

05 de Julio de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;GOMEZ COMINO BARRILERO CECILIO;FERNANDEZGOROSTIAGA CAMARA EDUARDO;BARRERO VAZQUEZ BERTA. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Revocaciones.Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Nombramientos. Consejero: AZUARASANCHEZ RAMON;GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Vicepresid.: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Co.De.Ma.So: GARCIALOPEZ-GASCO JERONIMO;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Apo.Man.Soli: SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 30892 ,F 132, S 8, H M 473412, I/A 14 (28.06.13).

30 de Enero de 2012
Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Vicepresid.: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Co.De.Ma.So: GARCIAPRIETO RAIMUNDO. Nombramientos. Consejero: BARRERO VAZQUEZ BERTA. Datos registrales. T 26274 , F 125, S 8, H M473412, I/A 13 (18.01.12).

27 de Julio de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCEDO MORENO MANUEL;CASTRO LOPEZ AVELINO. Vicepresid.: CASTRO LOPEZ AVELINO.Nombramientos. Consejero: GARCIA PRIETO RAIMUNDO;JIMENEZ REDONDO JOSE ANTONIO;GOMEZ COMINO BARRILEROCECILIO;FERNANDEZ GOROSTIAGA CAMARA EDUARDO. Vicepresid.: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Datos registrales. T 26274, F 124, S 8, H M 473412, I/A 11 (16.07.10).

Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: CASTRO LOPEZ AVELINO. Nombramientos. Co.De.Ma.So: GARCIA PRIETO RAIMUNDO.Datos registrales. T 26274 , F 125, S 8, H M 473412, I/A 12 (16.07.10).

28 de Abril de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 26274 , F 124, S 8, H M 473412, I/A10 (19.04.10).

23 de Abril de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO MAROTO RAFAEL. Nombramientos. Consejero: CASTRO LOPEZ AVELINO. Datosregistrales. T 26274 , F 122, S 8, H M 473412, I/A 7 (13.04.10).

Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Vicepresid.: CASTRO LOPEZ AVELINO.Datos registrales. T 26274 , F 123, S 8, H M 473412, I/A 8 (13.04.10).

Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Co.De.Ma.So: CASTRO LOPEZ AVELINO.Datos registrales. T 26274 , F 123, S 8, H M 473412, I/A 9 (13.04.10).

30 de Julio de 2009
Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Cons.Del.Man: LIZCANOABENGOZAR JOAQUIN;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Revocaciones. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSEMIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Nombramientos. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZARJOAQUIN. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 26274 , F 119, S8, H M 473412, I/A 6 (16.07.09).

24 de Febrero de 2009
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Cons.Del.Sol:VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Cons.Del.Man: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;VALLEJO ABADSEGUNDO. Datos registrales. T 26274 , F 117, S 8, H M 473412, I/A 4 (13.02.09).

Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 26274 , F118, S 8, H M 473412, I/A 5 (13.02.09).

12 de Enero de 2009
Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 4.11.08. Objeto social: EL DESARROLLO Y EJECUCION DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO INTEGRAL DE MATERIAL FERROVIARIO E INSTALACIONES FERROVIARIAS. Domicilio: PASEO DELTRENTALGO 2 - LAS MATAS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Capital suscrito: 9.000.000,00 Euros. Desembolsado: 5.000.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: VALLEJO ABAD SEGUNDO;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;DOMINGUEZ ROA JULIOMARIA;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;ALCEDO MORENO MANUEL;ARROYO MAROTO RAFAEL. Datos registrales. T 26274 ,F 113, S 8, H M 473412, I/A 1 (24.12.08).

Nombramientos. Presidente: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. SecreNoConsj:SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL. Datos registrales. T 26274 , F 116, S 8, H M 473412, I/A 2 (24.12.08).

Nombramientos. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Datos registrales. T 26274 , F116, S 8, H M 473412, I/A 3 (24.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n