Actos BORME de Tarvia Mantenimiento Ferroviario Sa
04 de Agosto de 2023Ampliaci贸n de capital. Suscrito: 16.000.000,00 Euros. Desembolsado: 16.000.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.000.000,00Euros. Resultante Desembolsado: 24.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 42441 , F 41, S 8, H M 751074, I/A 5 (28.07.23).
26 de Agosto de 2022Nombramientos. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 42441 , F 41, S 8, H M 751074, I/A 4 (19.08.22).
22 de Octubre de 2021Nombramientos. Presidente: JUANAS GARRIDO YOLANDA. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. SecreNoConsj:AGUADO FERNANDEZ JUAN IGNACIO. Datos registrales. T 42441 , F 39, S 8, H M 751074, I/A 2 (15.10.21).
Nombramientos. Apoderado: JUANAS GARRIDO YOLANDA;FERNANDEZ SANCHEZ DEL PERAL FRANCISCO-JAVIER;LIZCANOABENGOZAR JOAQUIN;ALONSO MARTIN-LOECHES JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 42441 , F 40, S 8, H M 751074, I/A 3(15.10.21).
22 de Septiembre de 2021Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 29.04.21. Objeto social: El desarrollo y ejecuci贸n de trabajos de mantenimiento integral detrenes del parque de veh铆culos propiedad del Grupo Renfe, mediante el mantenimiento o reparaci贸n de toda clase de elementosindustriales, electr贸nicos, el茅ctricos o mec谩nicos, incluyendo todas las tareas propias de ingenier铆a,. Domicilio: PASEO DEL TRENTALGO 2 (ROZAS DE MADRID (LAS)). Capital suscrito: 8.000.000,00 Euros. Desembolsado: 8.000.000,00 Euros. Nombramientos.Consejero: JUANAS GARRIDO YOLANDA;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;SEGURA ECHANIZ ALVARO;LIZCANO ABENGOZARJOAQUIN;MINAYO DE LA CRUZ MIGUEL FELIX;VICENTE CALADO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 42441 , F 36, S 8, H M751074, I/A 1 (15.09.21).
27 de Diciembre de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: VALLEJO ABAD SEGUNDO;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA.Presidente: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Vicepresid.: HENAR PEREZ LUIS ALFONSO. Secretario: DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA.Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA. Disoluci贸n. Fusion. Extinci贸n. Datos registrales. T30892 , F 135, S 8, H M 473412, I/A 17 (19.12.13).
14 de Noviembre de 2013Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: PATENTES TALGO SL. Datos registrales. T 30892 , F 135, S 8, H M 473412, I/A16 ( 6.11.13).
12 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Secretario: SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL. Consejero: JIMENEZ REDONDO JOSEANTONIO;AZUARA SANCHEZ RAMON;GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Vicepresid.: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO.Co.De.Ma.So: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Nombramientos. Vicepresid.: HENAR PEREZLUIS ALFONSO. Secretario: DOMINGUEZ ROA JULIO MARIA. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;DOMINGUEZ ROA JULIO
05 de Julio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;GOMEZ COMINO BARRILERO CECILIO;FERNANDEZGOROSTIAGA CAMARA EDUARDO;BARRERO VAZQUEZ BERTA. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Revocaciones.Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Nombramientos. Consejero: AZUARASANCHEZ RAMON;GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Vicepresid.: GARCIA LOPEZ-GASCO JERONIMO. Co.De.Ma.So: GARCIALOPEZ-GASCO JERONIMO;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Apo.Man.Soli: SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 30892 ,F 132, S 8, H M 473412, I/A 14 (28.06.13).
30 de Enero de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Vicepresid.: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Co.De.Ma.So: GARCIAPRIETO RAIMUNDO. Nombramientos. Consejero: BARRERO VAZQUEZ BERTA. Datos registrales. T 26274 , F 125, S 8, H M473412, I/A 13 (18.01.12).
27 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ALCEDO MORENO MANUEL;CASTRO LOPEZ AVELINO. Vicepresid.: CASTRO LOPEZ AVELINO.Nombramientos. Consejero: GARCIA PRIETO RAIMUNDO;JIMENEZ REDONDO JOSE ANTONIO;GOMEZ COMINO BARRILEROCECILIO;FERNANDEZ GOROSTIAGA CAMARA EDUARDO. Vicepresid.: GARCIA PRIETO RAIMUNDO. Datos registrales. T 26274, F 124, S 8, H M 473412, I/A 11 (16.07.10).
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: CASTRO LOPEZ AVELINO. Nombramientos. Co.De.Ma.So: GARCIA PRIETO RAIMUNDO.Datos registrales. T 26274 , F 125, S 8, H M 473412, I/A 12 (16.07.10).
28 de Abril de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 4.000.000,00 Euros. Datos registrales. T 26274 , F 124, S 8, H M 473412, I/A10 (19.04.10).
23 de Abril de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: ARROYO MAROTO RAFAEL. Nombramientos. Consejero: CASTRO LOPEZ AVELINO. Datosregistrales. T 26274 , F 122, S 8, H M 473412, I/A 7 (13.04.10).
Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Vicepresid.: CASTRO LOPEZ AVELINO.Datos registrales. T 26274 , F 123, S 8, H M 473412, I/A 8 (13.04.10).
Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Co.De.Ma.So: CASTRO LOPEZ AVELINO.Datos registrales. T 26274 , F 123, S 8, H M 473412, I/A 9 (13.04.10).
30 de Julio de 2009Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Cons.Del.Man: LIZCANOABENGOZAR JOAQUIN;VALLEJO ABAD SEGUNDO. Revocaciones. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSEMIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Nombramientos. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZARJOAQUIN. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 26274 , F 119, S8, H M 473412, I/A 6 (16.07.09).
24 de Febrero de 2009Ceses/Dimisiones. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Nombramientos. Cons.Del.Sol:VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Cons.Del.Man: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;VALLEJO ABADSEGUNDO. Datos registrales. T 26274 , F 117, S 8, H M 473412, I/A 4 (13.02.09).
Nombramientos. Apoderado: ECHEVARRIA MELERO JOSE MIGUEL;SEGURA ECHANIZ ALVARO. Datos registrales. T 26274 , F118, S 8, H M 473412, I/A 5 (13.02.09).
12 de Enero de 2009Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 4.11.08. Objeto social: EL DESARROLLO Y EJECUCION DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO INTEGRAL DE MATERIAL FERROVIARIO E INSTALACIONES FERROVIARIAS. Domicilio: PASEO DELTRENTALGO 2 - LAS MATAS (ROZAS DE MADRID (LAS)). Capital suscrito: 9.000.000,00 Euros. Desembolsado: 5.000.000,00 Euros.Nombramientos. Consejero: VALLEJO ABAD SEGUNDO;HENAR PEREZ LUIS ALFONSO;DOMINGUEZ ROA JULIOMARIA;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN;ALCEDO MORENO MANUEL;ARROYO MAROTO RAFAEL. Datos registrales. T 26274 ,F 113, S 8, H M 473412, I/A 1 (24.12.08).
Nombramientos. Presidente: VALLEJO ABAD SEGUNDO. Vicepresid.: LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. SecreNoConsj:SEVILLANO RODRIGUEZ MARIA URIEL. Datos registrales. T 26274 , F 116, S 8, H M 473412, I/A 2 (24.12.08).
Nombramientos. Co.De.Ma.So: VALLEJO ABAD SEGUNDO;LIZCANO ABENGOZAR JOAQUIN. Datos registrales. T 26274 , F116, S 8, H M 473412, I/A 3 (24.12.08).