Actos BORME de Tasal Sl
23 de Diciembre de 2021Reelecciones. Aud.C.Con.: CB AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 4139 , F 106, S 8, H Z 2388, I/A 47(16.12.21).
17 de Noviembre de 2020Nombramientos. Cons.Del.Sol: SALINAS VILLALBA MILAGROS;CORTES ROYO JUAN JOSE. Reelecciones. Secretario:RODENAS RUBIO MARIA DE LAS MERCEDES. Consejero: SALINAS VILLALBA MILAGROS;RODENAS RUBIO MARIA DE LASMERCEDES;CORTES ROYO JUAN JOSE. Presidente: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Datos registrales. T 4139 , F 106, S 8, H Z2388, I/A 46 (11.11.20).
21 de Diciembre de 2018Revocaciones. Apoderado: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Apo.Manc.: SALINAS VILLALBA MILAGROS;MAYO REBOLLOAMANDO. Datos registrales. T 4139 , F 106, S 8, H Z 2388, I/A 45 (14.12.18).
14 de Noviembre de 2018Nombramientos. Aud.C.Con.: CB AUDITORES Y ASESORES SLP. Datos registrales. T 4139 , F 105, S 8, H Z 2388, I/A 44 (6.11.18).
06 de Noviembre de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: MAYO REBOLLO AMANDO. Datos registrales. T 4139 , F 105, S 8, H Z 2388, I/A 42 (30.10.18).
Nombramientos. Con.Delegado: CORTES ROYO JUAN JOSE. Datos registrales. T 4139 , F 105, S 8, H Z 2388, I/A 43 (30.10.18).
13 de Junio de 2018Modificaciones estatutarias. "ARTICULO 40.- Retribución de los consejeros. El cargo de consejero será retribuido. La retribuciónconsistirá en una cantidad fija anual pagadera en dinero. El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los consejerosdeberá ser aprobado por la Junta General y permanecerá vigente en. Datos registrales. T 4139 , F 105, S 8, H Z 2388, I/A 41 (6.06.18).
11 de Diciembre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SALINAS LAZARO MANUEL. Presidente: SALINAS LAZARO MANUEL. Vicepresid.: SALINASVILLALBA MILAGROS. Revocaciones. Apoderado: MAYO REBOLLO AMANDO;VILLALBA RAMON JOSE LUIS. Nombramientos.Presidente: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Cons.Del.Sol: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Modificaciones estatutarias. "Artículo
30 de Marzo de 2015Nombramientos. Apoderado: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Datos registrales. T 3562 , F 224, S 8, H Z 2388, I/A 39 (23.03.15).
09 de Octubre de 2012Ampliación de capital. Capital: 4.328.654,42 Euros. Resultante Suscrito: 20.151.175,41 Euros. Datos registrales. T 3562 , F 224, S8, H Z 2388, I/A 38 (28.09.12).
09 de Febrero de 2012Modificaciones estatutarias. ARTICULO 40. RETRIBUCION DE LOS CONSEJEROS. El cargo de Consejero será retribuido. Laretribución consistirá en la cantidad fija que para cada ejercicio acuerde la Junta General,la cual realizará también la distribución dedicha cantidadentre los administradores de la forma que estime oportuna, y. Datos registrales. T 3562 , F 223, S 8, H Z 2388, I/A 37(27.01.12).
16 de Abril de 2010Nombramientos. Consejero: MAYO REBOLLO AMANDO;CORTES ROYO JUAN JOSE. Reelecciones. Secretario: RODENASRUBIO MARIA DE LAS MERCEDES. Presidente: SALINAS LAZARO MANUEL. Consejero: SALINAS LAZARO MANUEL;SALINASVILLALBA MILAGROS;RODENAS RUBIO MARIA DE LAS MERCEDES. Vicepresid.: SALINAS VILLALBA MILAGROS. Datosregistrales. T 3562 , F 223, S 8, H Z 2388, I/A 36 ( 7.04.10).
18 de Marzo de 2010Fe de erratas: RECTIFICADA la escritura de poder otorgada el 8 de Febrero de 2008, en cuanto al nombre del apoderado Sr. MayoRebollo, que se publicó como "Armando", cuando el correcto es "AMANDO". Datos registrales. T 3562 , F 223, S 8, H Z 2388, I/A 35 (9.03.10).