Actos BORME de Taulell Sociedad Limitada
22 de Abril de 2022Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 24/01/2022. Sentencia de aprobaci贸ndel convenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE CASTELLO DE LA PLANA. Juez: FRANCISCO GILMONZO. Resoluciones: PRACTICADA LA INSCRIPCION de APROBACION de la propuesta de MODIFICACION del CONVENIOpresentada por la concursada "TAULELL, SL", CONFORME A LA LEY 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales yorganizativas para hacer frente al COVID-19 en el 谩mbito de la Administraci贸n de Justicia. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 107,S 8, H CS 6125, I/A 93 (13.04.22).
06 de Febrero de 2019Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 115.398,01 Euros. Resultante Suscrito: 398.456,99 Euros. Modificaciones estatutarias.Art铆culo de los estatutos: reduccion capital. mod. art.. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 107, S 8, H CS 6125, I/A 92 (21.01.19).
11 de Enero de 2019Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: Modificado el art铆culo 4潞 de los Estatutos Sociales por cambio de domiciliosocial. Cambio de domicilio social. C/ ISLAS CANARIAS 4 (ONDA). Datos registrales. T 1641, L 1203, F 107, S 8, H CS 6125, I/A91 (24.12.18).
29 de Agosto de 2018Revocaciones. Apoderado: CASA脩A PETIT PEDRO;GONZALEZ LACOMBA JOSE MARIA. Apo.Sol.: PORCAR CELDA LILIANA.Apoderado: MORENO NOGALES MARIA DE LOS ANGELES;HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO;VILLALONGA GUILLENFRANCISCO. Apo.Manc.: BADENES GOMEZ JUAN ELOY;DIAGO DE LA PRESENTACION FERNANDO;CASA脩A GOMEZ PEDROJUAN. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 106, S 8, H CS 6125, I/A 90 (22.08.18).
20 de Julio de 2018Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 3/01/2018. Sentencia de aprobaci贸n delconvenio. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ.Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 3/01/2018. Cese de las limitaciones delas facultades de administraci贸n. Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: ANTONIO PEDREIRAGONZALEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. Fecha de resoluci贸n 12/06/2015. Revocaci贸n deadministradores concursales. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: DON CARLOS JOSENU脩EZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 3/01/2018, NIF/CIF 18399543A. GAMBARO ROYO ROQUE. Situaci贸n concursal.Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 3/01/2018. Auto de formaci贸n de la secci贸n de calificaci贸n.Juzgado: num. 0 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ. Datos registrales.T 1641, L 1203, F 106, S 8, H CS 6125, I/A 89 (13.07.18).
22 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: FIDES AUDITORES SL. Otros conceptos: REVOCACION del actual auditor de las CUENTASINDIVIDUALES de la sociedad, Don Conrado Font Arquer -Auditor Titular-, y en su consecuencia, del Auditor Suplente Don Jos茅Vicente Grangel Seguer, para los EJERCICIOS 2017, 2018, 2019 y 2020. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 105, S 8, H CS 6125,I/A 88 ( 9.01.18).
01 de Diciembre de 2017Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 31/03/2017. Auto de apertura de la fasede convenio. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: DON ANTONIO PEDREIRA GONZALEZ.Datos registrales. T 1641, L 1203, F 105, S 8, H CS 6125, I/A 87 (24.11.17).
03 de Octubre de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: RODRIGUEZ VIDAL JOSE FRANCISCO;CABEDO ALBERT JOAQUIN;CABEDO ALBERT JOAQUIN;SIMOAYZA MANUEL. Nombramientos. Apoderado: DIAGO DE LA PRESENTACION FERNANDO. Datos registrales. T 1641, L 1203, F104, S 8, H CS 6125, I/A 86 (23.09.16).
09 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Aud.C.Con.: LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Aud.C.Con.: GRANGEL SEGUER JOSE VICENTE.Aud.Supl.C.C: FONT ARQUER CONRADO. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 104, S 8, H CS 6125, I/A 85 ( 1.10.15).
08 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Auditor: LOPEZ GOMEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Auditor: FONT ARQUER CONRADO. Aud.Supl.:GRANGEL SEGUER JOSE VICENTE. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 104, S 8, H CS 6125, I/A 84 ( 1.10.15).
18 de Agosto de 2015Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/06/2015. Auto de declaraci贸n deconcurso. Voluntario. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: DON CARLOS JOSE NU脩EZLOPEZ. Situaci贸n concursal. Procedimiento concursal 000232/2015. FIRME: Si, Fecha de resoluci贸n 12/06/2015. Resolucionesacordando la intervenci贸n o suspensi贸n de las factultades de administraci贸n y disposici贸n del concursado. Juzgado: num. 1 JUZGADODE LO MERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: DON CARLOS JOSE NU脩EZ LOPEZ. Situaci贸n concursal. Procedimientoconcursal 000232/2015. Fecha de resoluci贸n 12/06/2015. Nombramiento de administradores. Juzgado: num. 1 JUZGADO DE LOMERCANTIL N潞1 DE CASTELLON. Juez: DON CARLOS JOSE NU脩EZ LOPEZ. Administrador Concursal. Fecha 12/06/2015, NIF/CIF18399543A. GAMBARO ROYO ROQUE. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 103, S 8, H CS 6125, I/A 83 ( 7.08.15).
09 de Febrero de 2015Revocaciones. Apo.Sol.: VALLVE MARSOL SANTIAGO. Apo.Manc.: CASA脩A GOMEZ JOSE VICENTE. Datos registrales. T 1641,L 1203, F 103, S 8, H CS 6125, I/A 82 ( 2.02.15).
11 de Julio de 2014Revocaciones. Apo.Manc.: VALLVE MARSOL SANTIAGO;CABEDO ALBERT JOAQUIN. Apo.Sol.: VALLVE MARSOLSANTIAGO;VALLVE MARSOL SANTIAGO;VALLVE MARSOL SANTIAGO. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 103, S 8, H CS6125, I/A 81 ( 4.07.14).
28 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: BADENES GOMEZ CRISTOBAL JUAN;CASA脩A GOMEZ PEDRO JUAN;DIAGO DE LAPRESENTACION IGNACIO;BADENES GRANELL CRISTOBAL;BADENES GOMEZ JUAN ELOY;CASA脩A GOMEZ JOSEVICENTE;NEMOPRO SL. Presidente: BADENES GOMEZ CRISTOBAL JUAN. Vicepresid.: CASA脩A GOMEZ PEDRO JUAN.Vicesecret.: DIAGO DE LA PRESENTACION IGNACIO. Secretario: NEMOPRO SL. Nombramientos. Consejero: LAUBERHORNSL;GESTION INMOBILIARIA Y MARITIMA EUROPEA SL;ELBRUS GESTION SOCIEDAD LIMITADA. Presidente: LAUBERHORN SL.Secretario: GESTION INMOBILIARIA Y MARITIMA EUROPEA SL. Cons.Del.Man: LAUBERHORN SL;GESTION INMOBILIARIA YMARITIMA EUROPEA SL;ELBRUS GESTION SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 102, S 8, H CS 6125, I/A79 (21.03.14).
Nombramientos. Apo.Manc.: BADENES GOMEZ JUAN ELOY;DIAGO DE LA PRESENTACION FERNANDO;CASA脩A GOMEZPEDRO JUAN. Datos registrales. T 1641, L 1203, F 102, S 8, H CS 6125, I/A 80 (21.03.14).
03 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: QUEROL SANJUAN JUAN ANTONIO. Apo.Manc.: QUEROL SANJUAN JUAN ANTONIO. Datosregistrales. T 1641, L 1203, F 102, S 8, H CS 6125, I/A 78 (24.02.14).
21 de Febrero de 2014Nombramientos. Apoderado: MORENO NOGALES MARIA DE LOS ANGELES;HERNANDEZ RODRIGUEZ JOSEANTONIO;VILLALONGA GUILLEN FRANCISCO. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 225, S 8, H CS 6125, I/A 77 (14.02.14).
24 de Junio de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: A-CUBOS ARQUITECTURA QUEROL SOCIEDAD LIMITADA. Nombramientos. Consejero:QUEROL SANJUAN JUAN ANTONIO. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 225, S 8, H CS 6125, I/A 76 (17.06.13).
28 de Mayo de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: QUEROL SANJUAN JUAN ANTONIO. Secretario: DIAGO DE LA PRESENTACION FERNANDO.Consejero: DIAGO DE LA PRESENTACION FERNANDO. Nombramientos. Consejero: A-CUBOS ARQUITECTURA QUEROLSOCIEDAD LIMITADA;NEMOPRO SL. Secretario: NEMOPRO SL. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 225, S 8, H CS 6125, I/A 75(17.05.13).
21 de Septiembre de 2012Revocaciones. Apo.Sol.: GARCIA MENDEZ FERNANDO. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 224, S 8, H CS 6125, I/A 73(12.09.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: VALLVE MARSOL SANTIAGO;SIMO AYZA MANUEL;PORCAR CELDA LILIANA. Datos registrales. T1578, L 1140, F 224, S 8, H CS 6125, I/A 74 (12.09.12).
14 de Agosto de 2012Reelecciones. Auditor: KPMG AUDITORES SL. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 224, S 8,H CS 6125, I/A 72 ( 1.08.12).
19 de Abril de 2012Revocaciones. Apoderado: DUART DUART SALVADOR;DUART DUART SALVADOR;DUART DUART SALVADOR. Datosregistrales. T 1578, L 1140, F 224, S 8, H CS 6125, I/A 71 ( 4.04.12).
10 de Febrero de 2012Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ LACOMBA JOSE MARIA. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 223, S 8, H CS 6125, I/A70 ( 1.02.12).
30 de Enero de 2012Nombramientos. Apoderado: DUART DUART SALVADOR. Datos registrales. T 1578, L 1140, F 223, S 8, H CS 6125, I/A 69(18.01.12).