Actos BORME de Tave Sl
08 de Junio de 2023Revocaciones. APOD.SOL/MAN: FERNANDEZ ALVAREZ MARIA SONIA. Datos registrales. T 40166 , F 6, S 8, H B 28269, I/A 34 (1.06.23).
11 de Diciembre de 2020Nombramientos. APOD.SOL/MAN: FERNANDEZ ALVAREZ MARIA SONIA. Datos registrales. T 40166 , F 5, S 8, H B 28269, I/A33 ( 1.12.20).
20 de Marzo de 2020Revocaciones. APODERADO: GONZALEZ RUBIO ANTONIO;MARTINEZ GARCIA JUAN JOSE. Datos registrales. T 40166 , F 4, S8, H B 28269, I/A 32 (12.03.20).
13 de Enero de 2020Revocaciones. APOD.SOL/MAN: FONTDECABA ANTICO JORGE. Nombramientos. APOD.SOL/MAN: FONTDECABA ANTICOJORGE;VELAZQUEZ MOREU CARLOS. Datos registrales. T 40166 , F 3, S 8, H B 28269, I/A 31 ( 2.01.20).
13 de Diciembre de 2019Nombramientos. APODERAD.SOL: FONTDECABA ANTICO JORGE;VELAZQUEZ MOREU CARLOS. Datos registrales. T 40166 ,F 3, S 8, H B 28269, I/A 30 ( 3.12.19).
24 de Julio de 2019Cambio de domicilio social. CL BALMES NUM.96 P.1 PTA.1 A (BARCELONA). Datos registrales. T 40166 , F 3, S 8, H B 28269,I/A 29 (16.07.19).
13 de Marzo de 2019Nombramientos. APOD.SOL/MAN: FONTDECABA ANTICO JORGE. Datos registrales. T 40166 , F 2, S 8, H B 28269, I/A 28 (5.03.19).
12 de Marzo de 2015Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: CARLES BATLLO MARIA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: FRANCO CARLES FRANCISCO.Datos registrales. T 40166 , F 2, S 8, H B 28269, I/A 27 ( 4.03.15).
06 de Marzo de 2012Revocaciones. ADM.SOLIDAR.: MIQUEL CHAUMONT MAGDALENA. Nombramientos. ADM.SOLIDAR.: GESTORUM SL.REPR.143 RRM: GABARRO MIQUEL MAGDALENA. Datos registrales. T 40166 , F 2, S 8, H B 28269, I/A 26 (24.02.12).