Actos BORME de Tax Legal Abogados Slp
28 de Diciembre de 2017Ceses/Dimisiones. Consejero: ROGER JAUME BRUMWELL GUILERA. Datos registrales. T 2805 , F 193, S 8, H GI 32706, I/A 14(20.12.17).
23 de Junio de 2014Cambio de domicilio social. C/ ALEMANYA 14 - RECINTO FERIAL (FIGUERES). Datos registrales. T 2805 , F 193, S 8, H GI32706, I/A 13 (16.06.14).
20 de Febrero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: LUIS ALBERTO GARCIA ALONSO. Secretario: LUIS ALBERTO GARCIA ALONSO. Cons.Del.Sol:LUIS ALBERTO GARCIA ALONSO. Nombramientos. Secretario: FRANCESC PEREZ VIZCAINO. Datos registrales. T 2805 , F193, S 8, H GI 32706, I/A 12 ( 8.02.13).
11 de Enero de 2012Cambio de domicilio social. CTRA BARCELONA 2 3 1 (GIRONA). Datos registrales. T 2805 , F 193, S 8, H GI 32706, I/A 11(30.12.11).
19 de Enero de 2010Nombramientos. CONS. DELEG.: MARTINEZ BONDE PETERSEN HELENA. Datos registrales. T 37542 , F 23, S 8, H B 303077,I/A 10 ( 7.01.10).
10 de Diciembre de 2009Otros conceptos: ADMISION DE HELENA MARTINEZ BONDE PETERSEN COMO NUEVA SOCIAPROFESIONAL YCONSECUENTES CAMBIOS EN LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos registrales. T 37542 , F 22, S 8, H B 303077, I/A 9(27.11.09).