Actos BORME de Tdn Segovia Avila Sl
26 de Octubre de 2022Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 149 , F 156, S 8, H SG 3325, I/A 16 (19.10.22).
03 de Diciembre de 2021Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TDN SA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA GARCIA PEDRO ANTONIO.Nombramientos. Adm. Unico: TDN SA. Datos registrales. T 149 , F 156, S 8, H SG 3325, I/A 15 (29.11.21).
20 de Noviembre de 2019Cierre provisional hoja registral por baja en el 铆ndice de Entidades Jur铆dicas. Datos registrales. T 149 , F 156, S 8, H SG 3325,I/ANota1 ( 9.10.19).
Reapertura hoja registral. Datos registrales. T 149 , F 156, S 8, H SG 3325, I/ANota1 (13.11.19).
24 de Marzo de 2011Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO AREMAYO CARLOS. Datos registrales. T 149 , F 155, S 8, H SG 3325, I/A 14(15.03.11).
21 de Diciembre de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: PRIETO HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO;ALVAREZ CERVELL MANUEL. Datos registrales. T 149 , F154, S 8, H SG 3325, I/A 12 (13.12.10).
Nombramientos. Apoderado: FRANCISCO BAEZA ARANZAZU. Datos registrales. T 149 , F 154, S 8, H SG 3325, I/A 13(13.12.10).
13 de Abril de 2010Nombramientos. Apoderado: DE LA OSA MACHI FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 149 , F 154, S 8, H SG 3325, I/A 11(30.03.10).
18 de Marzo de 2010Revocaciones. Apo.Sol.: BLANCO PEREZ JULIO. Datos registrales. T 149 , F 154, S 8, H SG 3325, I/A 10 (10.03.10).
15 de Abril de 2009Revocaciones. Apo.Sol.: MU脩OZ ORTEGA JUAN. Datos registrales. T 149 , F 154, S 8, H SG 3325, I/A 9 ( 2.04.09).
10 de Febrero de 2009Nombramientos. Apo.Sol.: BLANCO PEREZ JULIO;LOPEZ FERRERO JOSE-LUIS. Datos registrales. T 149 , F 154, S 8, H SG3325, I/A 8 (28.01.09).