Buscador CIF Logo

Actos BORME Te Connectivity Spain Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Te Connectivity Spain Sa

Actos BORME Te Connectivity Spain Sa - A28754604

Tenemos registrados 12 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Te Connectivity Spain Sa con CIF A28754604

馃敊 Perfil de Te Connectivity Spain Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Te Connectivity Spain Sa

06 de Junio de 2016
Disoluci贸n. Voluntaria. Extinci贸n. Datos registrales. T 33405 , F 10, S 8, H M 68464, I/A 99 (30.05.16).

19 de Abril de 2016
Otros conceptos: CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LOPRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM. Datos registrales. T 33405 , F 10, S 8, H M 68464, I/A 98M ( 8.04.16).

26 de Febrero de 2016
Nombramientos. Apo.Manc.: SVENSSON MAGNUS;ARMELIN BABLER JOAO VITOR;GEROSA MICHAEL;THURNHEERELEONORA;GIOVENALI ALESSANDRA. Datos registrales. T 33405 , F 10, S 8, H M 68464, I/A 98 (18.02.16).

24 de Diciembre de 2015
Ceses/Dimisiones. SecreNoConsj: OLIVARES MARTIN JUAN. Revocaciones. Apoderado: SILES MARTIN LUIS;SUAREZGARNELO ANA. Nombramientos. SecreNoConsj: KALMYKOVA MARIANNA. Apoderado: TEJERO SARRION EDUARDO;SUAREZTRAMON ALBERTO;VILALTA DUCE ALBERTO. Datos registrales. T 33405 , F 9, S 8, H M 68464, I/A 97 (16.12.15).

17 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 33405 , F 9, S 8, H M 68464, I/A 96 ( 7.12.15).

06 de Noviembre de 2015
Revocaciones. Apo.Manc.: OLIVARES MARTIN JUAN;RUANO ALVARO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ CARNICERO VICTOR.Nombramientos. Apo.Man.Soli: BARTES BLAZQUEZ CARLOS;SOLERA DONATE MARIA DEL MAR;BEJAR NAVARROJAVIER;RUANO ALVARO MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 33405 , F 2, S 8, H M 68464, I/A 95 (29.10.15).

27 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: DE CRAEMER DAVID. Vicepresid.: DE CRAEMER DAVID. Nombramientos. Consejero: DAUKAUSSTEPHEN MARK. Vicepresid.: DAUKAUS STEPHEN MARK. Datos registrales. T 33405 , F 2, S 8, H M 68464, I/A 94 (19.10.15).

06 de Octubre de 2015
Ampliacion del objeto social. La prestaci贸n de servicios administrativos, de contabilidad, tesorer铆a, de recursos humanos, log铆stica,fiscales o laborales, por cuenta propia o a trav茅s de terceros. Datos registrales. T 33405 , F 1, S 8, H M 68464, I/A 93 (28.09.15).

06 de Julio de 2015
Reelecciones. Consejero: BARKSDALE HAROLD-GREGORY. Datos registrales. T 33405 , F 1, S 8, H M 68464, I/A 92 (29.06.15).

28 de Abril de 2015
Revocaciones. Apo.Man.Soli: OLIVARES MARTIN JUAN;RUANO ALVARO MIGUEL ANGEL. Nombramientos. Apo.Manc.:OLIVARES MARTIN JUAN;RUANO ALVARO MIGUEL ANGEL;SANCHEZ CARNICERO VICTOR. Datos registrales. T 25010 , F155, S 8, H M 68464, I/A 91 (21.04.15).

30 de Octubre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 25010 , F 154, S 8, H M 68464, I/A 90 (22.10.14).

03 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: KERCKHOFS VITAL LUC VICTOR. Vicepresid.: KERCKHOFS VITAL LUC VICTOR.Nombramientos. Consejero: DE CRAEMER DAVID. Vicepresid.: DE CRAEMER DAVID. Datos registrales. T 25010 , F 154, S 8, HM 68464, I/A 89 (23.09.14).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n