Buscador CIF Logo

Actos BORME Teckel Gestora Sl

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Teckel Gestora Sl

Actos BORME Teckel Gestora Sl - B79165569

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Teckel Gestora Sl con CIF B79165569

馃敊 Perfil de Teckel Gestora Sl
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Teckel Gestora Sl

26 de Junio de 2023
Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ GARCIA MARIA ALEJANDRA;ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS. Datosregistrales. T 37451 , F 84, S 8, H M 23543, I/A 75 (19.06.23).

02 de Febrero de 2023
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.351.437,43 Euros. Resultante Suscrito: 54.729.252,34 Euros. Datos registrales. T37451 , F 83, S 8, H M 23543, I/A 73 (26.01.23).

Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37451 , F 84, S 8, H M 23543, I/A 74 (26.01.23).

20 de Diciembre de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;ALCOBENDAS RODRIGUEZJUAN CARLOS;MESEGUER MU脩OZ LUIS;YEBES CAMA脩O ELENA. Apo.Man.Soli: LOSANTOS EGEA DANIEL;MESEGUERMU脩OZ LUIS. Nombramientos. Apo.Sol.: MORENO CASTELLANOS MARIA. Apo.Manc.: MORENO CASTELLANOS MARIA;DE LAPE脩A SAINZ MARIA;DIEZ SOLER LORENA;DIEZ SOLER LORENA;DE LA PE脩A SAINZ MARIA;ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUANCARLOS;MORENO CASTELLANOS MARIA;YEBES CAMA脩O ELENA. Datos registrales. T 37451 , F 82, S 8, H M 23543, I/A 72(13.12.22).

26 de Octubre de 2022
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 2.169.290,69 Euros. Resultante Suscrito: 57.293.628,21 Euros. Datos registrales. T37451 , F 81, S 8, H M 23543, I/A 70 (19.10.22).

Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1.212.938,44 Euros. Resultante Suscrito: 56.080.689,77 Euros. Datos registrales. T37451 , F 81, S 8, H M 23543, I/A 71 (19.10.22).

16 de Agosto de 2022
Modificaciones estatutarias. Modificado el art铆culo 11潞 de los estatutos sociales mediante una nueva e 铆ntegra redacci贸n de este,a帽adiendo el 11.bis y 11.ter. Datos registrales. T 37451 , F 80, S 8, H M 23543, I/A 69 ( 8.08.22).

04 de Julio de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO.Apoderado: GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO. Datos registrales. T 37451 , F 80, S 8, H M 23543, I/A 68 (27.06.22).

03 de Febrero de 2022
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37451 , F 80, S 8, H M 23543, I/A 67 (27.01.22).

30 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37451 , F 80, S 8, H M 23543, I/A 66 (23.11.20).

20 de Noviembre de 2020
Nombramientos. Apoderado: ALVAREZ GARCIA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 37451 , F 79, S 8, H M 23543, I/A 65(13.11.20).

24 de Julio de 2020
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOSANTOS EGEA DANIEL;LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA. Nombramientos. Adm.Unico: LOSANTOS EGEA DANIEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administradores solidarios aAdministrador 煤nico. Datos registrales. T 37451 , F 79, S 8, H M 23543, I/A 64 (17.07.20).

02 de Diciembre de 2019
Reelecciones. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 37451 , F 79, S 8, H M 23543, I/A 63 (25.11.19).

18 de Octubre de 2019
Otros conceptos: Modificaci贸n de la Disposici贸n Final de los estatutos sociales relativa al sometimiento a arbitraje para la resoluci贸nde conflictos.- Datos registrales. T 37451 , F 78, S 8, H M 23543, I/A 62 (11.10.19).

12 de Julio de 2019
Modificaciones estatutarias. Art铆culo de los estatutos: 2. Domicilio social . MODIFICACION DEL ARTICULO 18潞 DE LOSESTATUTOS SOCIALES.. Cambio de domicilio social. AVDA PIO XII 44 - EDIFICIO OFICINAS, PLANTA 2 (MADRID). Datosregistrales. T 37451 , F 78, S 8, H M 23543, I/A 61 ( 5.07.19).

24 de Junio de 2019
Revocaciones. Apoderado: CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Apoderado: DIEZ SOLER LORENA.Datos registrales. T 37451 , F 77, S 8, H M 23543, I/A 60 (17.06.19).

20 de Junio de 2019
Ceses/Dimisiones. Consejero: LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA;LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS

11 de Abril de 2018
Revocaciones. Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;TOPOLSKA BARBARA MARTA.Nombramientos. Apoderado: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;CORTIJO FERNANDEZFRANCISCO JAVIER;CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO;DE LA PE脩A SAINZ MARIA. Datos registrales. T 29492 , F 70, S 8, H M23543, I/A 58 ( 4.04.18).

13 de Febrero de 2018
Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOSANTOS EGEA DANIEL;LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA. Nombramientos. Consejero:LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA;LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO. Presidente:LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA. Secretario: LOSANTOS EGEA DANIEL. Cons.Del.Sol: LOSANTOS DEL CAMPO JOSEMARIA;LOSANTOS EGEA DANIEL. Modificaciones estatutarias. 18. RETRIBUCION . Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Administradores solidarios a Consejo de administraci贸n. Cambio de objeto social. Compraventa de bienesinmobiliarios por cuenta propia. Datos registrales. T 29492 , F 69, S 8, H M 23543, I/A 57 ( 5.02.18).

22 de Diciembre de 2017
Nombramientos. Aud.C.Con.: KPMG AUDITORES SL. Datos registrales. T 29492 , F 69, S 8, H M 23543, I/A 56 (13.12.17).

03 de Julio de 2017
Nombramientos. Apo.Manc.: CEBALLOS FERNANDEZ EDUARDO;CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER;GONZALEZMARTIN CARLOS FERNANDO;GUIRAO PEREZ MARTA MARIA. Datos registrales. T 29492 , F 68, S 8, H M 23543, I/A 55(23.06.17).

18 de Enero de 2017
Ampliaci贸n de capital. Capital: 35.181.009,78 Euros. Resultante Suscrito: 59.462.918,90 Euros. Datos registrales. T 29492 , F 67,S 8, H M 23543, I/A 54 (10.01.17).

08 de Febrero de 2016
Ampliaci贸n de capital. Capital: 3.479,00 Euros. Resultante Suscrito: 24.281.909,12 Euros. Otros conceptos: CREADAS 2CLASES DE PARTICIPACIONES SOCIALES, CLASES A Y B, MODIFICANDO EL ARTICULO 5潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES; YMODIFICADOS LOS ARTICULOS 6, 13 Y LA DISPOSICION FINAL DE LOS CITADOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales.T 29492 , F 65, S 8, H M 23543, I/A 52 (28.01.16).

Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOSANTOS DEL CAMPO JOSE MARIA. Nombramientos. Adm. Solid.: LOSANTOS DEL CAMPOJOSE MARIA;LOSANTOS EGEA DANIEL. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administraci贸n: Administrador 煤nico aAdministradores solidarios. Datos registrales. T 29492 , F 67, S 8, H M 23543, I/A 53 (28.01.16).

17 de Julio de 2015
Cambio de objeto social. A) La adquisici贸n, por cualquier titulo legal, de toda clase de bienes inmuebles, terrenos r煤sticos y urbanos,edificios, viviendas y locales de negocio, as铆 como su explotaci贸n en r茅gimen de propiedad, arrendamiento o cesi贸n de uso. B) Laactividad de construcci贸n... Datos registrales. T 29492 , F 65, S 8, H M 23543, I/A 51 ( 8.07.15).

20 de Enero de 2015
Modificaciones estatutarias. MODIFICACION DEL ARTICULO 18潞 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos registrales. T 29492 ,F 64, S 8, H M 23543, I/A 50 (12.01.15).

16 de Enero de 2015
Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 5.080.395,84 Euros. Resultante Suscrito: 24.278.430,12 Euros. Datos registrales. T29492 , F 64, S 8, H M 23543, I/A 49 ( 8.01.15).

09 de Octubre de 2014
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;LOPEZ BOUZA RUBEN.Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;CORTIJO FERNANDEZ FRANCISCOJAVIER;ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS;LOPEZ BOUZA RUBEN;YEBES CAMA脩O ELENA. Datos registrales. T29492 , F 63, S 8, H M 23543, I/A 46 ( 2.10.14).

Nombramientos. Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;CORTIJO FERNANDEZ

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;MESEGUER MU脩OZ LUIS.Datos registrales. T 29492 , F 63, S 8, H M 23543, I/A 48 ( 2.10.14).

13 de Enero de 2014
Nombramientos. Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;CORTIJO FERNANDEZFRANCISCO JAVIER;ALCOBENDAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS;LOPEZ BOUZA RUBEN;YEBES CAMA脩O ELENA. Datosregistrales. T 29492 , F 62, S 8, H M 23543, I/A 45 (30.12.13).

09 de Octubre de 2013
Revocaciones. Apoderado: LOSANTOS EGEA DANIEL;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;MEDINASANCHEZ ROSA MARIA;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;MEDINA MARTINEZCARLOS;LOSANTOS EGEA DANIEL. Datos registrales. T 29492 , F 60, S 8, H M 23543, I/A 42 ( 1.10.13).

Nombramientos. Apo.Manc.: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;TOPOLSKA BARBARAMARTA. Datos registrales. T 29492 , F 61, S 8, H M 23543, I/A 43 ( 1.10.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSANTOS EGEA DANIEL;GONZALEZ MARTIN CARLOS FERNANDO;LOPEZ BOUZA RUBEN.Datos registrales. T 29492 , F 62, S 8, H M 23543, I/A 44 ( 1.10.13).

16 de Enero de 2012
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOSANTOS SANTORROMAN CARMEN;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;LAGARES GOMEZ-ABASCALMANUEL;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T 17480 , F 142, S 8, H M 23543, I/A 39 ( 3.01.12).

Nombramientos. Apoderado: LOSANTOS EGEA DANIEL;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE. Datosregistrales. T 17480 , F 142, S 8, H M 23543, I/A 40 ( 3.01.12).

Nombramientos. Apoderado: MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;GONZALEZ MARTIN CARLOSFERNANDO;MEDINA MARTINEZ CARLOS;LOSANTOS EGEA DANIEL. Datos registrales. T 17480 , F 144, S 8, H M 23543, I/A 41 (3.01.12).

09 de Marzo de 2011
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOSANTOS SANTORROMAN JOSE-MARIA. Datos registrales. T 17480 , F 142, S 8, H M 23543, I/A38 (28.02.11).

02 de Septiembre de 2010
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;LOSANTOS DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER;LOSANTOSSANTORROMAN CARMEN;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;LOSANTOS DEL CAMPO FRANCISCO JAVIER;LOSANTOSSANTORROMAN JOSE-MARIA;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA;LOSANTOS SANTORROMAN CARMEN. Apo.Man.Soli:LOSANTOS SANTORROMAN CARMEN. Datos registrales. T 17480 , F 140, S 8, H M 23543, I/A 36 (24.08.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOSANTOS SANTORROMAN CARMEN;LOPEZ SANCHEZ ENRIQUE;LOSANTOSSANTORROMAN JOSE-MARIA;LAGARES GOMEZ-ABASCAL MANUEL;MEDINA SANCHEZ ROSA MARIA. Datos registrales. T17480 , F 140, S 8, H M 23543, I/A 37 (24.08.10).

05 de Enero de 2009
Revocaciones. Apo.Man.Soli: GONZALEZ RUIZ TEODORO JULIO. Datos registrales. T 17480 , F 140, S 8, H M 23543, I/A 35(17.12.08).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n