Actos BORME de Tecnatom Servicios Tecnicos Y Consultoria Sl
03 de Agosto de 2023Revocaciones. Apoderado: AGUERO AGUERO JORGE-JUAN. Nombramientos. Apoderado: LOIZAGA DIAZ I脩IGO. Datosregistrales. T 37182 , F 106, S 8, H M 556112, I/A 23 (27.07.23).
15 de Marzo de 2023Nombramientos. Apoderado: MARTINEZ ZORITA MARTA;CHAMORRO GARIJO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 37182 , F106, S 8, H M 556112, I/A 22 ( 8.03.23).
10 de Marzo de 2023Revocaciones. Apoderado: LOPEZ PEREZ-HERVADA LUCIA;MINERVINI MARCOS KARINA VIVIANA. Nombramientos.Apoderado: RIBALDA GALAN MARIA. Datos registrales. T 37182 , F 105, S 8, H M 556112, I/A 21 ( 3.03.23).
18 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: AGUERO AGUERO JORGE-JUAN. Datos registrales. T 37182 , F 102, S 8, H M 556112, I/A 19(11.06.19).
14 de Junio de 2019Nombramientos. Apoderado: CALDERON DELGADO LEOPOLDO. Datos registrales. T 37182 , F 102, S 8, H M 556112, I/A 18 (7.06.19).
02 de Abril de 2019Revocaciones. Apoderado: SERRANO VIZCAINO JOSE. Datos registrales. T 37182 , F 102, S 8, H M 556112, I/A 17 (26.03.19).
07 de Junio de 2018Revocaciones. Apo.Sol.: GONZALEZ ALVAREZ EMILIO;BRIME GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 30898 , F194, S 8, H M 556112, I/A 14 (29.05.18).
Nombramientos. Apoderado: CHAMORRO GARIJO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30898 , F 194, S 8, H M 556112, I/A 15(29.05.18).
Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL. Nombramientos. Adm. Mancom.: CHAMORROGARIJO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 30898 , F 194, S 8, H M 556112, I/A 16 (29.05.18).
26 de Marzo de 2018Revocaciones. Apoderado: ROBLES ESTEBAN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 30898 , F 192, S 8, H M 556112, I/A 12(19.03.18).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ PEREZ-HERVADA LUCIA. Datos registrales. T 30898 , F 192, S 8, H M 556112, I/A 13(19.03.18).
31 de Enero de 2017Ampliacion del objeto social. Prestacion de toda clase de servicios de soporte a emergencias. Datos registrales. T 30898 , F 143,S 8, H M 556112, I/A 11 (23.01.17).
05 de Julio de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Mancom.: GONZALEZ ALVAREZ EMILIO. Nombramientos. Adm. Mancom.: GONZALEZ MANTECACORAL. Cambio de domicilio social. AVDA MONTES DE OCA 4 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Datos registrales. T 30898, F 143, S 8, H M 556112, I/A 10 (27.06.16).
02 de Marzo de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: SANCHEZ PEREZ LORENZO ENRIQUE. Datos registrales. T 30898 , F 143, S 8, H M 556112, I/A 9(24.02.16).
02 de Julio de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL;SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE;GONZALEZALVAREZ EMILIO. Presidente: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL. Con.Delegado: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL.SecreNoConsj: BRIME GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Nombramientos. Adm. Mancom.: MOURIN VALCARCEL JOSEMANUEL;SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE;GONZALEZ ALVAREZ EMILIO. Otros conceptos: Cambio del Organo deAdministraci贸n: Consejo de administraci贸n a Administradores mancomunados. Datos registrales. T 30898 , F 143, S 8, H M 556112,I/A 8 (25.06.15).
23 de Diciembre de 2014Modificaciones estatutarias. Se han modificado los articulos 2, 3, 7, 12 y 13 de los Estatutos Sociales.. Cambio de domiciliosocial. AVDA DE SOMOSIERRA 12 (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Cambio de objeto social. a) La prestaci贸n de toda clasede servicios de ingenier铆a, en toda su amplitud, incluidos los de asesoramiento, auditor铆a, consultor铆a, formaci贸n, investigaci贸n yestudios de ingenier铆a, y en particular todos los que tengan relaci贸n con la tecnolog铆a de inspecci贸n y pruebas, mantenimiento,segurida. Datos registrales. T 30898 , F 142, S 8, H M 556112, I/A 7 (16.12.14).
29 de Abril de 2013Nombramientos. Apoderado: ROBLES ESTEBAN FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 30898 , F 134, S 8, H M 556112, I/A 3(19.04.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE;GONZALEZ ALVAREZ EMILIO. Datos registrales. T 30898 ,F 136, S 8, H M 556112, I/A 4 (19.04.13).
Nombramientos. Apoderado: SERRANO VIZCAINO JOSE. Datos registrales. T 30898 , F 138, S 8, H M 556112, I/A 5 (19.04.13).
Nombramientos. Apo.Sol.: SANCHEZ PEREZ LORENZO ENRIQUE;BRIME GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales.T 30898 , F 140, S 8, H M 556112, I/A 6 (19.04.13).
24 de Abril de 2013Nombramientos. Presidente: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL. Con.Delegado: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL.SecreNoConsj: BRIME GONZALEZ FRANCISCO JAVIER. Datos registrales. T 30898 , F 133, S 8, H M 556112, I/A 2 (17.04.13).
08 de Abril de 2013Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 6.03.13. Objeto social: a) La prestaci贸n de toda clase de servicios de ingenier铆a, en toda suamplitud, incluidos los de asesoramiento, auditor铆a, consultor铆a, formaci贸n, investigaci贸n y estudios de ingenier铆a, y en particular todoslos que tengan relaci贸n con la tecnolog铆a de inspecci贸n y pruebas, mantenimiento, seguridad. Domicilio: AVDA MONTES DE OCA 4(SAN SEBASTIAN DE LOS REYES). Capital: 3.000,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TECNATOM SA.Nombramientos. Consejero: MOURIN VALCARCEL JOSE MANUEL;SANCHEZ ALVAREZ FRANCISCO JOSE;GONZALEZALVAREZ EMILIO. Datos registrales. T 30898 , F 132, S 8, H M 556112, I/A 1 (21.03.13).