Actos BORME de Tecnica De Transportes Internacionales Sociedad Anonima
24 de Marzo de 2022Nombramientos. Apoderado: JUAN FRANCISCO VILLADANGOS GARCIA. Datos registrales. T 32078 , F 48, S 8, H M 577300, I/A17 (17.03.22).
Nombramientos. Apoderado: NUNEZ JEAN DENIS. Datos registrales. T 32078 , F 48, S 8, H M 577300, I/A 18 (17.03.22).
Nombramientos. Apoderado: NUNEZ JEAN DENIS;JUAN FRANCISCO VILLADANGOS GARCIA. Datos registrales. T 32078 , F49, S 8, H M 577300, I/A 19 (17.03.22).
Ceses/Dimisiones. Consejero: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL;CANDONI MARIE CLAUDE;BOVIS ENZO;SCRIVATMATHIEU VINCENT MICHEL. Presidente: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL. Secretario: SCRIVAT MATHIEU VINCENTMICHEL. Nombramientos. Consejero: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL. Presidente: BOVIS PASCAL MAURICEEMMANUEL. Consejero: CANDONI MARIE CLAUDE;BOVIS ENZO. Secretario: BOVIS ENZO. Datos registrales. T 32078 , F 50, S8, H M 577300, I/A 20 (17.03.22).
20 de Abril de 2021Reelecciones. Auditor: MOORE IBERICA DE AUDITORIA SLP. Datos registrales. T 32078 , F 47, S 8, H M 577300, I/A 16(13.04.21).
02 de Marzo de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: PASCUAL ALCALA ROSA;QUILEZ COLET PERE. Datos registrales. T 32078 , F 47, S 8, H M577300, I/A 15 (24.02.20).
22 de Febrero de 2019Reelecciones. Consejero: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL;CANDONI MARIE CLAUDE;BOVIS ENZO;SCRIVAT MATHIEUVINCENT MICHEL. Presidente: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL. Secretario: SCRIVAT MATHIEU VINCENT MICHEL. Datosregistrales. T 32078 , F 47, S 8, H M 577300, I/A 14 (15.02.19).
07 de Marzo de 2018Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 32078 , F 46, S 8, H M 577300, I/A13 (27.02.18).
24 de Abril de 2017Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 32078 , F 46, S 8, H M 577300, I/A12 (17.04.17).
07 de Abril de 2016Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 32078 , F 46, S 8, H M 577300, I/A11 (30.03.16).
24 de Junio de 2015Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LAS INSCRIPCIONES 3& Y 5& EL NOMBRAMIENTO DE SCRIVAT MATHIEUVICENT MICHEL, SIENDO LO CORRECTO SCRIVAT MATHIEU VINCENT MICHEL. Datos registrales. T 32078 , F 40, S 8, H M577300, I/A 3 (14.03.14).
10 de Abril de 2015Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 32078 , F 46, S 8, H M 577300, I/A10 ( 1.04.15).
04 de Noviembre de 2014Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 32078 , F 45, S 8, H M 577300, I/A9 (27.10.14).
23 de Junio de 2014Nombramientos. Apoderado: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL. Datos registrales. T 32078 , F 44, S 8, H M 577300, I/A 7(12.06.14).
Revocaciones. Apoderado: VALLE DIAZ SONIA;VALLE DIAZ SONIA. Datos registrales. T 32078 , F 45, S 8, H M 577300, I/A 8(12.06.14).
24 de Marzo de 2014Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: BOVIS PASCAL MAURICE EMMANUEL. Nombramientos. Consejero: BOVIS PASCAL MAURICEEMMANUEL;CANDONI MARIE CLAUDE;BOVIS ENZO;SCRIVAT MATHIEU VICENT MICHEL. Presidente: BOVIS PASCAL MAURICEEMMANUEL. Secretario: SCRIVAT MATHIEU VICENT MICHEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo deAdministración: Administrador único a Consejo de administración. 15. Determinación de la estructura.. 16. Duración, Retribución..Datos registrales. T 32078 , F 40, S 8, H M 577300, I/A 3 (14.03.14).
Nombramientos. Apoderado: CANDONI MARIE CLAUDE. Datos registrales. T 32078 , F 41, S 8, H M 577300, I/A 4 (17.03.14).
Nombramientos. Apoderado: SCRIVAT MATHIEU VICENT MICHEL. Datos registrales. T 32078 , F 42, S 8, H M 577300, I/A 5(17.03.14).
Revocaciones. Apoderado: ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION. Datos registrales. T 32078 , F 44, S 8, H M577300, I/A 6 (17.03.14).
21 de Marzo de 2014Cambio de domicilio social. C/ GALILEO GALILEI 23 - POLIGONO INDUSTRIAL "LA GA (ALCALA DE HENARES). Datosregistrales. T 32078 , F 40, S 8, H M 577300, I/A 2 (14.03.14).
04 de Marzo de 2014Nombramientos. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 14, S 8, H V 9447,I/A 61 (25.02.14).
Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: ARTICULO 19.- EJERCICIO SOCIAL: Los ejercicios sociales se iniciarán eldía 1 de Abril y se cerrarán el día 31 de marzo de cada año, estableciéndose por tanto, una vez cerrado el ejercicio del año 2013 al día31 de Diciembre de dicho año, un periodo contable transitorio. Datos registrales. T 3659, L 971, F 14, S 8, H V 9447, I/A 62(25.02.14).
26 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apoderado: ROMERO CASTAÑEDA LUIS JESUS;TEBA ESTEBAN JULIA SOFIA. Datos registrales. T 3659, L 971,F 14, S 8, H V 9447, I/A 60 (17.12.13).
25 de Septiembre de 2013Nombramientos. Apoderado: VILLADANGOS GARCIA JUAN FRANCISCO. Datos registrales. T 3659, L 971, F 13, S 8, H V 9447,I/A 58 (18.09.13).
Nombramientos. Apoderado: TUDA GONZALEZ MARIA TERESA. Datos registrales. T 3659, L 971, F 13, S 8, H V 9447, I/A 59(18.09.13).
20 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apoderado: BERNAOLA MARTIN IÑIGO. Apo.Manc.: BERNAOLA MARTIN IÑIGO. Datos registrales. T 3659, L971, F 13, S 8, H V 9447, I/A 57 (13.09.13).
10 de Septiembre de 2013Declaración de unipersonalidad. Socio único: BOVIS PARTICIPATION SA. Ceses/Dimisiones. Consejero: ROMEROCASTAÑEDA LUIS JESUS;ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION;VALLE DIAZ SONIA. Secretario: ROMEROCASTAÑEDA LUIS JESUS. Presidente: ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION. Nombramientos. Adm. Unico: BOVISPASCAL MAURICE EMMANUEL. Modificaciones estatutarias. Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración aAdministrador único. Datos registrales. T 3659, L 971, F 13, S 8, H V 9447, I/A 56 ( 3.09.13).
09 de Septiembre de 2013Revocaciones. Apoderado: GUZMAN MARTINEZ ANTONIO JAVIER;ESTESO LOPEZ MANUELA;SANCHEZ SERRANO MARIACRISTINA;ALCOLEA BERROCOSA NATAN;MORAL PEREZ MIGUEL JOSE. Apo.Manc.: MORAL PEREZ MIGUEL JOSE. Apoderado:MARTIN LAZARO YOLANDA. Datos registrales. T 3659, L 971, F 12, S 8, H V 9447, I/A 55 ( 2.09.13).
19 de Diciembre de 2012Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 12, S 8, H V 9447,I/A 54 (12.12.12).
09 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 12, S 8, H V 9447,I/A 53 (28.12.11).
31 de Octubre de 2011Cambio de objeto social. 1).- La sociedad tiene por objeto el transporte terrestre de todo tipo de mercancías, tanto en territorionacional como internacional. 2).- La consignación de buques de cargas y descarga y tránsito de mercancías, agencia de fletamentos yen general cualquier actividad relacionada con el tráfico marí. Datos registrales. T 3659, L 971, F 12, S 8, H V 9447, I/A 52(20.10.11).
22 de Julio de 2011Otros conceptos: La página web de la Sociedad es www.tti-transport.com, a efectos de hacer constar la dirección web corporativa.Datos registrales. T 3659, L 971, F 11, S 8, H V 9447, I/A 50 (13.07.11).
Ampliacion del objeto social. La mediación en la venta de billetes o reservas de plazas, en toda clase de transporte, asi como en lasreservas de habitaciones y servicios en las empresas turísticas, y particularmente en los establecimientos hoteleros y en el resto dealojamientos turísticos. La organización y la venta de las lla. Datos registrales. T 3659, L 971, F 11, S 8, H V 9447, I/A 51 (13.07.11).
30 de Mayo de 2011Revocaciones. Apo.Manc.: VALLE DIAZ SONIA. Apo.Sol.: VALLE DIAZ SONIA. Apo.Manc.: TORRES MUZAS NURIA. Datosregistrales. T 3659, L 971, F 11, S 8, H V 9447, I/A 49 (19.05.11).
19 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 11, S 8, H V 9447,I/A 48 (10.01.11).
15 de Julio de 2010Ceses/Dimisiones. Secretario: ROMERO CASTAÑEDA LUIS JESUS. Consejero: ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LACONCEPCION;VALLE DIAZ SONIA;MORAL PEREZ MIGUEL JOSE.Presidente: ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION.Nombramientos. Consejero: ROMERO CASTAÑEDA LUIS JESUS;ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION;VALLE DIAZSONIA. Secretario: ROMERO CASTAÑEDA LUIS JESUS. Presidente: ESTEBAN PASCUAL MARIA DE LA CONCEPCION. Datosregistrales. T 3659, L 971, F 11, S 8, H V 9447, I/A 47 ( 5.07.10).
04 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: VALLE DIAZ SONIA. Apo.Manc.: BERNAOLA MARTIN IÑIGO. Datos registrales. T 3659, L 971, F 10,S 8, H V 9447, I/A 46 (25.05.10).
06 de Abril de 2010Nombramientos. Apo.Sol.: VALLE DIAZ SONIA. Apo.Manc.: VALLE DIAZ SONIA;TORRES MUZAS NURIA. Datos registrales. T3659, L 971, F 10, S 8, H V 9447, I/A 45 (24.03.10).
27 de Enero de 2010Nombramientos. Apoderado: TEBA ESTEBAN JULIA SOFIA. Datos registrales. T 3659, L 971, F 9, S 8, H V 9447, I/A 42(18.01.10).
Revocaciones. Apoderado: GUILLERMO FRAILE ASUNCION. Apo.Manc.: GUILLERMO FRAILE ASUNCION. Apoderado: ESTEBANPASCUAL RICARDO. Datos registrales. T 3659, L 971, F 10, S 8, H V 9447, I/A 43 (18.01.10).
Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 10, S 8, H V 9447,I/A 44 (18.01.10).
18 de Marzo de 2009Reelecciones. Auditor: MOORE STEPHENS IBERICA DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 3659, L 971, F 8, S 8, H V 9447, I/A41 ( 9.03.09).