Buscador CIF Logo

Actos BORME Tecnicarton Sl

¿Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la información de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tecnicarton Sl

Actos BORME Tecnicarton Sl - B82248550

Tenemos registrados 41 Actos BORME del Registro Mercantil de Valencia para Tecnicarton Sl con CIF B82248550

🔙 Perfil de Tecnicarton Sl
🛒 Comprar listado completo de Empresas de Valencia

Actos BORME de Tecnicarton Sl

22 de Mayo de 2023
Revocaciones. Apoderado: LARA PIQUER MARIA CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MORENO CARLOS. Datosregistrales. T 7916, L 5211, F 193, S 8, H V 75237, I/A 52 (15.05.23).

Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL CASTILLO VILLANUEVAFERNANDO. Datos registrales. T 7916, L 5211, F 193, S 8, H V 75237, I/A 53 (15.05.23).

13 de Abril de 2023
Revocaciones. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;ALVAREZ TOQUERO MARIAESTELA Nombramientos. Apo.Manc.: DIEZ GONZALEZ BELEN. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 61, S 8, H V 75237, I/A 51 (4.04.23).

09 de Marzo de 2023
Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 61,S 8, H V 75237, I/A 50 ( 1.03.23).

11 de Agosto de 2022
Revocaciones. Apo.Manc.: MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Apo.Man.Soli: BENITO FERNANDEZ CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ PABLO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 59, S8, H V 75237, I/A 49 ( 3.08.22).

20 de Mayo de 2022
Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINO LOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;JUAREZMERINO MARIA JESUS;NIETO RAPOSO NESTOR;NUÑEZ MAGRO ANA MARIA;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO. Datosregistrales. T 7617, L 4917, F 59, S 8, H V 75237, I/A 48 (12.05.22).

27 de Abril de 2022
Nombramientos. Apo.Sol.: ALTAMIRANO RETAMOSO LISSET;BETEGON BADAS LAURA. Apo.Manc.: ALVAREZ TOQUEROMARIA ESTELA;BLANCO EXCALONA MARIA DEL PILAR;SIMION ALEXANDRA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V75237, I/A 47 (20.04.22).

11 de Junio de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V 75237, I/A46 ( 4.06.21).

11 de Mayo de 2021
Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSO OSCAR. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V75237, I/A 45 ( 3.05.21).

03 de Marzo de 2021
Revocaciones. Apo.Manc.: RIZZI PATRIZZIA. Apo.Sol.: RIZZI PATRIZIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO FERNANDEZCARMEN;ALVAREZ DOMIGUEZ RUT. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 57, S 8, H V75237, I/A 44 (24.02.21).

01 de Septiembre de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORREA FORTEA FRANCISCO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 57, S 8, H V 75237, I/A 43(25.08.20).

21 de Agosto de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSOOSCAR;ORTUÑO SIERRA MARIA CONCEPCION;IBAÑEZ PARADA MARIA LUISA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 56, S 8, HV 75237, I/A 42 (14.08.20).

24 de Febrero de 2020
Nombramientos. Apo.Manc.: FERREIRA MARQUES CARDOSO CARDOSO TIAGO;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;FRAILEORDUÑA NIEVES. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 39 (17.02.20).

Revocaciones. Apo.Manc.: CORREA FORTEA FRANCISCO. Apo.Man.Soli: TEJEDOR ANDRES PEDRO LUCAS. Apo.Manc.:PALACIOS ABRIL HECTOR. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 40 (17.02.20).

Nombramientos. Apo.Manc.: VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 41(17.02.20).

07 de Febrero de 2020
Revocaciones. Apo.Manc.: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE.Apo.Sol.: RIZZI PATRIZIA;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 38(31.01.20).

10 de Abril de 2019
Otros conceptos: Don Jeremy Andrew Aron, que fue designado como persona física representante de la entidad DS SMITHPACKAGING HOLDING, S.L. Unipersonal, en el cargo de Administrador Unico de la Sociedad de esta hoja, ha sido sustituido por ,DON IGNACIO MONTFORT GUASCH, mayor de edad, con DNI 46622058T,. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V75237, I/A28/ma ( 3.04.19).

02 de Abril de 2019
Revocaciones. Apo.Manc.: OULDARBIA OULDARBIA NOURA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 54, S 8, H V 75237, I/A 36(26.03.19).

Revocaciones. Apo.Manc.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR ANDRES PEDRO LUCAS.Datos registrales. T 7617, L 4917, F 54, S 8, H V 75237, I/A 37 (26.03.19).

04 de Febrero de 2019
Otros conceptos: Don Jason Michael Taylor ha sido sustituido por DON JEREMY ANDREW ARON, como persona físicarepresentante del Administrador Unico de la sociedad de esta hoja, la entidad DS SMITH PACKAGING HOLDING, SL. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A28/M2 (28.01.19).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Apo.Sol.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Apo.Manc.: RIZZIPATRIZZIA;PALACIOS ABRIL HECTOR;PALACIO CABRERO JOSE MANUEL;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO;OULDARBIAOULDARBIA NOURA;PAR UMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 35 (28.01.19).

23 de Julio de 2018
Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTEGA PINAR FRANCISCO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 34(16.07.18).

30 de Mayo de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 33 (23.05.18).

12 de Febrero de 2018
Otros conceptos: Don Jean Lienhardt, persona física representante del administrador único la mercantil "DS SMITH PACKAGINGHOLDING S.L", ha sido sustituido por DON JASON MICHAEL TAYLOR, NIE X6584936J, en escritura otorgada el 24/05/2017 por elNotario de Madrid, Don José Rivas Guardo nº 1323 de protocolo. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V 75237, I/A 28 M (5.02.18).

Nombramientos. Apoderado: LARA PIQUER MARIA CARMEN. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 223, S 8, H V 75237, I/A 32 (5.02.18).

16 de Mayo de 2017
Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOMAS TAPIA JOSE MARIA;CORREA FORTEA FRANCISCO. Datos registrales. T 6786, L 4090,F 222, S 8, H V 75237, I/A 31 ( 8.05.17).

30 de Marzo de 2016
Ceses/Dimisiones. Consejero: LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Secretario:ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Presidente: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Adm. Unico: DS SMITH PACKAGINGHOLDING SL. Auditor: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 23º.- El ejercicio socialcomienza el día 1 de mayo de cada año y termina el 30 de abril del año siguiente". Modificado el art. 16 en cuanto a que el cargo deadministrador pasa a ser gratuito.. ARTICULO 17.- Cuando la administración recaiga en un Consejo de Administración, se observaránlas reglas siguientes: b) El número de consejeros no podrá ser inferior a tres (3) ni superior a doce (12). b) El Consejo deAdministración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los "ARTICULO 19.- La representación de la Sociedad, enjuicio y fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada en el artículo 233 de la Ley, y de conformidad con laforma de administración elegida por la Junta General en cada momento. La representación se extenderá a todos los "ARTICULO 21.-No podrán ser nombrados administradores quienes se hallen comprendidos en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad legal oprohibición para ejercer el cargo, especialmente las determinadas por el artículo 213 de la Ley, la Ley 3/2015, de 30 de marzo y otrasespecíficas de las. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Cambio de domicilio social. C/ CANAL CRESPO 13 - PARQUE INDUSTRIAL JUAN CARLOS (ALMUSSAFES). Datos registrales.T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V 75237, I/A 28 (21.03.16).

Nombramientos. Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZSERRANO ISABEL;PEREZ-MANSILLA DELGADO PATRICIA;RUIZ PEÑA SUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 219, S 8, H V 75237, I/A 29 (21.03.16).

Revocaciones. Apoderado: ORTEGA PINAR FRANCISCO. Apo.Sol.: SANCHEZ OLIVO AURELIO;PEREZ CARSI JOSEMANUEL;SEVILLA GARCIA BARTOLOME;CORREA FORTEA FRANCISCO;MARTIN MIRAVENT LUIS;GAYOSO VAZQUEZROBERTO;ALVAREZ JURADO MIGUEL ANGEL;ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO. Apoderado: ARRUFAT DE LA TORREFERNANDO. Apo.Sol.: LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;SANCHEZ DAFOS JOSEANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA PINAR FRANCISCO;ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO;FORCADELLBEL JOAN ALBERT. Apo.Manc.: GIL SORIANO AMPARO;TOMAS TAPIA JOSE MARIA;CORREA FORTEA FRANCISCO. Apo.Sol.:GAYOSO VAZQUEZ ROBERTO;SEVILLA GARCIA BARTOLOME;RODRIGUEZ LOPEZ RUTH;BARREIRO REBOREDO MIGUELANGEL;ALVAREZ JURADO MIGUEL ANGEL;AYAS CARRETERO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 219, S8, H V 75237, I/A 30 (21.03.16).

28 de Octubre de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES;HOLZBACHER VALERO ENRIC. Vicepresid.: LANTERO MORENOANDRES. Cons.Del.Sol: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: LANTERO MORENO ANDRES. Presidente: HOLZBACHERVALERO ENRIC. Cons.Del.Sol: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Nombramientos. Presidente: ARON JEREMY ANDREW.Consejero: LIENHARDT JEAN;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Secretario: ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Apo.Sol.:LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;SANCHEZ DAFOS JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 217, S 8, H V 75237, I/A 27 (21.10.15).

24 de Febrero de 2015
Ceses/Dimisiones. Consejero: SHAW MARK. Nombramientos. Consejero: ARON JEREMY ANDREW. Datos registrales. T 6786,L 4090, F 217, S 8, H V 75237, I/A 26 (17.02.15).

24 de Diciembre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: AMELA AYORA ANTONIO. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: AMELA AYORAANTONIO. Nombramientos. Secretario: LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 217, S 8, H V 75237,I/A 25 (17.12.14).

07 de Octubre de 2014
Ceses/Dimisiones. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO MORENO ANDRES;AMELA AYORAANTONIO;SHAW MARK. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN.Vicepresid.: LANTERO MORENO ANDRES. Cons.Del.Sol: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO.Cons.Del.Sol: AMELA AYORA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENOANDRES;AMELA AYORA ANTONIO;SHAW MARK. Presidente: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Vicepresid.: LANTERO MORENOANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: AMELA AYORA ANTONIO;HOLZBACHER VALEROENRIC;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A 24 (30.09.14).

11 de Abril de 2013
Ceses/Dimisiones. Consejero: CRONIN MICHAEL FRANCIS. Nombramientos. Consejero: SHAW MARK. Datos registrales. T6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A 23 ( 4.04.13).

31 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6786, L 4090, F216, S 8, H V 75237, I/A 22 (22.10.12).

26 de Marzo de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: STEAD DAVID RICHARD. Nombramientos. Consejero: CRONIN MICHAEL FRANCIS. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A 21 (16.03.10).

11 de Febrero de 2010
Ceses/Dimisiones. Consejero: LANTERO ROZPIDE JORGE;MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;AMELA AYORA ANTONIO.Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Vicepresid.: LANTERO ROZPIDE JORGE. Secretario: AMELA AYORAANTONIO. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO ROZPIDE JORGE;AMELA AYORA ANTONIO.Consejero: ALMOND JOHN PHILLIP. Nombramientos. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO MORENOANDRES;AMELA AYORA ANTONIO;STEAD DAVID RICHARD. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Vicepresid.:LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGEESTEBAN;LANTERO MORENO ANDRES;AMELA AYORA ANTONIO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A20 ( 2.02.10).

22 de Diciembre de 2009
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6786, L4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A 19 (11.12.09).

08 de Julio de 2009
Nombramientos. Apoderado: ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V 75237, I/A18 (29.06.09).

13 de Febrero de 2009
Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V75237, I/A 17 ( 4.02.09).

15 de Enero de 2009
Ceses/Dimisiones. Consejero: WILLIAMS JOHN DAVID. Nombramientos. Consejero: ALMOND JOHN PHILLIP. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V 75237, I/A 16 ( 5.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades analíticas, de personalización, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnología. Si acepta o continúa navegando, consideramos que está de acuerdo con su uso. Mas información