Actos BORME de Tecnicarton Sl
22 de Mayo de 2023Revocaciones. Apoderado: LARA PIQUER MARIA CARMEN. Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ MORENO CARLOS. Datosregistrales. T 7916, L 5211, F 193, S 8, H V 75237, I/A 52 (15.05.23).
Revocaciones. Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: DEL CASTILLO VILLANUEVAFERNANDO. Datos registrales. T 7916, L 5211, F 193, S 8, H V 75237, I/A 53 (15.05.23).
13 de Abril de 2023Revocaciones. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;ALVAREZ TOQUERO MARIAESTELA Nombramientos. Apo.Manc.: DIEZ GONZALEZ BELEN. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 61, S 8, H V 75237, I/A 51 (4.04.23).
09 de Marzo de 2023Revocaciones. Auditor: DELOITTE SL. Nombramientos. Auditor: ERNST & YOUNG SL. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 61,S 8, H V 75237, I/A 50 ( 1.03.23).
11 de Agosto de 2022Revocaciones. Apo.Manc.: MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Apo.Man.Soli: BENITO FERNANDEZ CARMEN. Nombramientos.Apo.Man.Soli: TOMAS CASSINGENA SUSANA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ RUIZ PABLO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 59, S8, H V 75237, I/A 49 ( 3.08.22).
20 de Mayo de 2022Nombramientos. Apo.Manc.: GONZALEZ MARTINEZ DAVID;MERINO LOPEZ VICTOR;CAMARERO CARRION CRISTINA;JUAREZMERINO MARIA JESUS;NIETO RAPOSO NESTOR;NUÑEZ MAGRO ANA MARIA;DEL BARRIO VAQUERO ALVARO. Datosregistrales. T 7617, L 4917, F 59, S 8, H V 75237, I/A 48 (12.05.22).
27 de Abril de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: ALTAMIRANO RETAMOSO LISSET;BETEGON BADAS LAURA. Apo.Manc.: ALVAREZ TOQUEROMARIA ESTELA;BLANCO EXCALONA MARIA DEL PILAR;SIMION ALEXANDRA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V75237, I/A 47 (20.04.22).
11 de Junio de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V 75237, I/A46 ( 4.06.21).
11 de Mayo de 2021Revocaciones. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSO OSCAR. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 58, S 8, H V75237, I/A 45 ( 3.05.21).
03 de Marzo de 2021Revocaciones. Apo.Manc.: RIZZI PATRIZZIA. Apo.Sol.: RIZZI PATRIZIA. Nombramientos. Apo.Man.Soli: BENITO FERNANDEZCARMEN;ALVAREZ DOMIGUEZ RUT. Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 57, S 8, H V75237, I/A 44 (24.02.21).
01 de Septiembre de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: CORREA FORTEA FRANCISCO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 57, S 8, H V 75237, I/A 43(25.08.20).
21 de Agosto de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: BARRIOS RABAZAS ALFONSO. Apo.Sol.: FERNANDEZ PLEGUEZUELOS ALFONSOOSCAR;ORTUÑO SIERRA MARIA CONCEPCION;IBAÑEZ PARADA MARIA LUISA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 56, S 8, HV 75237, I/A 42 (14.08.20).
24 de Febrero de 2020Nombramientos. Apo.Manc.: FERREIRA MARQUES CARDOSO CARDOSO TIAGO;CALLEJA GUERRA JULIO JOSE;FRAILEORDUÑA NIEVES. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 39 (17.02.20).
Revocaciones. Apo.Manc.: CORREA FORTEA FRANCISCO. Apo.Man.Soli: TEJEDOR ANDRES PEDRO LUCAS. Apo.Manc.:PALACIOS ABRIL HECTOR. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 40 (17.02.20).
Nombramientos. Apo.Manc.: VARELA RICO MARIA CRISTINA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 41(17.02.20).
07 de Febrero de 2020Revocaciones. Apo.Manc.: PALACIO CABRERO JOSE MANUEL. Nombramientos. Apo.Manc.: CALLEJA GUERRA JULIO JOSE.Apo.Sol.: RIZZI PATRIZIA;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 55, S 8, H V 75237, I/A 38(31.01.20).
10 de Abril de 2019Otros conceptos: Don Jeremy Andrew Aron, que fue designado como persona física representante de la entidad DS SMITHPACKAGING HOLDING, S.L. Unipersonal, en el cargo de Administrador Unico de la Sociedad de esta hoja, ha sido sustituido por ,DON IGNACIO MONTFORT GUASCH, mayor de edad, con DNI 46622058T,. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V75237, I/A28/ma ( 3.04.19).
02 de Abril de 2019Revocaciones. Apo.Manc.: OULDARBIA OULDARBIA NOURA. Datos registrales. T 7617, L 4917, F 54, S 8, H V 75237, I/A 36(26.03.19).
Revocaciones. Apo.Manc.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: TEJEDOR ANDRES PEDRO LUCAS.Datos registrales. T 7617, L 4917, F 54, S 8, H V 75237, I/A 37 (26.03.19).
04 de Febrero de 2019Otros conceptos: Don Jason Michael Taylor ha sido sustituido por DON JEREMY ANDREW ARON, como persona físicarepresentante del Administrador Unico de la sociedad de esta hoja, la entidad DS SMITH PACKAGING HOLDING, SL. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A28/M2 (28.01.19).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: FREIXAS ACHAERANDIO LOURDES. Apo.Sol.: PAR UMBERT JUAN PABLO. Apo.Manc.: RIZZIPATRIZZIA;PALACIOS ABRIL HECTOR;PALACIO CABRERO JOSE MANUEL;MORROS RODRIGUEZ IGNACIO;OULDARBIAOULDARBIA NOURA;PAR UMBERT JUAN PABLO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 35 (28.01.19).
23 de Julio de 2018Revocaciones. Apo.Man.Soli: ORTEGA PINAR FRANCISCO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 34(16.07.18).
30 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 224, S 8, H V 75237, I/A 33 (23.05.18).
12 de Febrero de 2018Otros conceptos: Don Jean Lienhardt, persona física representante del administrador único la mercantil "DS SMITH PACKAGINGHOLDING S.L", ha sido sustituido por DON JASON MICHAEL TAYLOR, NIE X6584936J, en escritura otorgada el 24/05/2017 por elNotario de Madrid, Don José Rivas Guardo nº 1323 de protocolo. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V 75237, I/A 28 M (5.02.18).
Nombramientos. Apoderado: LARA PIQUER MARIA CARMEN. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 223, S 8, H V 75237, I/A 32 (5.02.18).
16 de Mayo de 2017Nombramientos. Apo.Man.Soli: TOMAS TAPIA JOSE MARIA;CORREA FORTEA FRANCISCO. Datos registrales. T 6786, L 4090,F 222, S 8, H V 75237, I/A 31 ( 8.05.17).
30 de Marzo de 2016Ceses/Dimisiones. Consejero: LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Secretario:ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Presidente: ARON JEREMY ANDREW. Nombramientos. Adm. Unico: DS SMITH PACKAGINGHOLDING SL. Auditor: DELOITTE SL. Modificaciones estatutarias. Artículo de los estatutos: Artículo 23º.- El ejercicio socialcomienza el día 1 de mayo de cada año y termina el 30 de abril del año siguiente". Modificado el art. 16 en cuanto a que el cargo deadministrador pasa a ser gratuito.. ARTICULO 17.- Cuando la administración recaiga en un Consejo de Administración, se observaránlas reglas siguientes: b) El número de consejeros no podrá ser inferior a tres (3) ni superior a doce (12). b) El Consejo deAdministración será convocado por su Presidente o el que haga sus veces. Los "ARTICULO 19.- La representación de la Sociedad, enjuicio y fuera de él, corresponde a los administradores en la forma determinada en el artículo 233 de la Ley, y de conformidad con laforma de administración elegida por la Junta General en cada momento. La representación se extenderá a todos los "ARTICULO 21.-No podrán ser nombrados administradores quienes se hallen comprendidos en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad legal oprohibición para ejercer el cargo, especialmente las determinadas por el artículo 213 de la Ley, la Ley 3/2015, de 30 de marzo y otrasespecíficas de las. Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único.Cambio de domicilio social. C/ CANAL CRESPO 13 - PARQUE INDUSTRIAL JUAN CARLOS (ALMUSSAFES). Datos registrales.T 6786, L 4090, F 218, S 8, H V 75237, I/A 28 (21.03.16).
Nombramientos. Apo.Sol.: MAFUZ GUMIEL ROSA MARIA;DIAZ CRESPO ROSALIA;RODRIGUEZ TORRES IRIA;PEREZSERRANO ISABEL;PEREZ-MANSILLA DELGADO PATRICIA;RUIZ PEÑA SUSANA SONIA;RABES RODRIGUEZ MARTA. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 219, S 8, H V 75237, I/A 29 (21.03.16).
Revocaciones. Apoderado: ORTEGA PINAR FRANCISCO. Apo.Sol.: SANCHEZ OLIVO AURELIO;PEREZ CARSI JOSEMANUEL;SEVILLA GARCIA BARTOLOME;CORREA FORTEA FRANCISCO;MARTIN MIRAVENT LUIS;GAYOSO VAZQUEZROBERTO;ALVAREZ JURADO MIGUEL ANGEL;ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO. Apoderado: ARRUFAT DE LA TORREFERNANDO. Apo.Sol.: LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;SANCHEZ DAFOS JOSEANTONIO. Nombramientos. Apo.Man.Soli: ORTEGA PINAR FRANCISCO;ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO;FORCADELLBEL JOAN ALBERT. Apo.Manc.: GIL SORIANO AMPARO;TOMAS TAPIA JOSE MARIA;CORREA FORTEA FRANCISCO. Apo.Sol.:GAYOSO VAZQUEZ ROBERTO;SEVILLA GARCIA BARTOLOME;RODRIGUEZ LOPEZ RUTH;BARREIRO REBOREDO MIGUELANGEL;ALVAREZ JURADO MIGUEL ANGEL;AYAS CARRETERO MARCO ANTONIO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 219, S8, H V 75237, I/A 30 (21.03.16).
28 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: LANTERO MORENO ANDRES;HOLZBACHER VALERO ENRIC. Vicepresid.: LANTERO MORENOANDRES. Cons.Del.Sol: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: LANTERO MORENO ANDRES. Presidente: HOLZBACHERVALERO ENRIC. Cons.Del.Sol: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Nombramientos. Presidente: ARON JEREMY ANDREW.Consejero: LIENHARDT JEAN;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Secretario: ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER. Apo.Sol.:LIENHARDT JEAN;ARON JEREMY ANDREW;ORTEGA RAMOS CARLOS JAVIER;SANCHEZ DAFOS JOSE ANTONIO. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 217, S 8, H V 75237, I/A 27 (21.10.15).
24 de Febrero de 2015Ceses/Dimisiones. Consejero: SHAW MARK. Nombramientos. Consejero: ARON JEREMY ANDREW. Datos registrales. T 6786,L 4090, F 217, S 8, H V 75237, I/A 26 (17.02.15).
24 de Diciembre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: AMELA AYORA ANTONIO. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: AMELA AYORAANTONIO. Nombramientos. Secretario: LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 217, S 8, H V 75237,I/A 25 (17.12.14).
07 de Octubre de 2014Ceses/Dimisiones. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO MORENO ANDRES;AMELA AYORAANTONIO;SHAW MARK. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN.Vicepresid.: LANTERO MORENO ANDRES. Cons.Del.Sol: LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO.Cons.Del.Sol: AMELA AYORA ANTONIO. Nombramientos. Consejero: HOLZBACHER VALERO ENRIC;LANTERO MORENOANDRES;AMELA AYORA ANTONIO;SHAW MARK. Presidente: HOLZBACHER VALERO ENRIC. Vicepresid.: LANTERO MORENOANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: AMELA AYORA ANTONIO;HOLZBACHER VALEROENRIC;LANTERO MORENO ANDRES. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A 24 (30.09.14).
11 de Abril de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: CRONIN MICHAEL FRANCIS. Nombramientos. Consejero: SHAW MARK. Datos registrales. T6786, L 4090, F 216, S 8, H V 75237, I/A 23 ( 4.04.13).
31 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6786, L 4090, F216, S 8, H V 75237, I/A 22 (22.10.12).
26 de Marzo de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: STEAD DAVID RICHARD. Nombramientos. Consejero: CRONIN MICHAEL FRANCIS. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A 21 (16.03.10).
11 de Febrero de 2010Ceses/Dimisiones. Consejero: LANTERO ROZPIDE JORGE;MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;AMELA AYORA ANTONIO.Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Vicepresid.: LANTERO ROZPIDE JORGE. Secretario: AMELA AYORAANTONIO. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO ROZPIDE JORGE;AMELA AYORA ANTONIO.Consejero: ALMOND JOHN PHILLIP. Nombramientos. Consejero: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN;LANTERO MORENOANDRES;AMELA AYORA ANTONIO;STEAD DAVID RICHARD. Presidente: MALLO CARCIOFFI JORGE ESTEBAN. Vicepresid.:LANTERO MORENO ANDRES. Secretario: AMELA AYORA ANTONIO. Cons.Del.Sol: MALLO CARCIOFFI JORGEESTEBAN;LANTERO MORENO ANDRES;AMELA AYORA ANTONIO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A20 ( 2.02.10).
22 de Diciembre de 2009Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 6786, L4090, F 215, S 8, H V 75237, I/A 19 (11.12.09).
08 de Julio de 2009Nombramientos. Apoderado: ARRUFAT DE LA TORRE FERNANDO. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V 75237, I/A18 (29.06.09).
13 de Febrero de 2009Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V75237, I/A 17 ( 4.02.09).
15 de Enero de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: WILLIAMS JOHN DAVID. Nombramientos. Consejero: ALMOND JOHN PHILLIP. Datosregistrales. T 6786, L 4090, F 214, S 8, H V 75237, I/A 16 ( 5.01.09).