Actos BORME de Tecnicas Y Tratamientos Energeticos De Residuos Sa
03 de Febrero de 2016Ceses/Dimisiones. Secr.Com.Liq: TORRES AVILA PASCUAL FRANCISCO. Mmbr.Com.Liq: GALLEN TERRIZA VICENTE;DEBERNARDO SANCHIS ADOLFO;GALLEN RUIZ VICENTE-MANUEL;MENDOZA MARTOS MIGUEL ANGEL;QUILIS MERIN JULIOJOSE;TORRES AVILA PASCUAL FRANCISCO.Pres.Com.Liq: QUILIS MERIN JULIO JOSE. Extinción. Datos registrales. T 9024, L6309, F 219, S 8, H V 133594, I/A 12 (27.01.16).
03 de Julio de 2012Ceses/Dimisiones. Consejero: ESPINOSA BOLAÑOS FELIPE;LAMPARERO LAZARO JORGE ANTONIO;SERRANO MATEOCRISTINA. Datos registrales. T 9024, L 6309, F 218, S 8, H V 133594, I/A 9 (22.06.12).
08 de Julio de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS;MARTIN RUIZ ROCIO. Nombramientos. Consejero: GALLEN RUIZVICENTE-MANUEL;GALLEN TERRIZA VICENTE. Cambio de domicilio social. PASEO DE LA COSTERA 2 - URBANIZACIONMONASTERIOS (PUZOL). Datos registrales. T 9024, L 6309, F 218, S 8, H V 133594, I/A 8 (29.06.11).
13 de Abril de 2011Ceses/Dimisiones. Cons.Del.Sol: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS. Presidente: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS. Nombramientos.Presidente: QUILIS MERIN JULIO JOSE. Con.Delegado: QUILIS MERIN JULIO JOSE. Datos registrales. T 9024, L 6309, F 218, S 8,H V 133594, I/A 7 ( 4.04.11).
19 de Octubre de 2009Otros conceptos: Rectificada parcialmente la inscripción 6& de las transcritas bajo la 1& de ésta hoja, en el sentido de hacer constarque el UNICO CONSEJERO DELEGADO designado fue D. José Luís Muñoz Peirats, quedando sin efecto el nombramiento comoconsejero delegado a favor de D. Felipe Espinosa Bolaños.Rectificada parcialmente la inscripción 6& de las transcritas bajo la 1& deésta hoja, al haberse omitido el acuerdo dedeterminación del número de miembros del consejo de administración y su composición,que también fue adoptado por la propia junta universal de socios de 11 de febrero de 2009. Datos registrales. T 9024, L 6309, F 217,S 8, H V 133594, I/A 5 ( 7.10.09).
Ceses/Dimisiones. Con.Delegado: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS. Nombramientos. Cons.Del.Sol: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS.Datos registrales. T 9024, L 6309, F 217, S 8, H V 133594, I/A 6 ( 7.10.09).
16 de Octubre de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: SEBASTIA AGUILAR FRANCISCO JAVIER. Otros conceptos: Rectificada parcialmente lainscripción 4& de las transcritas bajo la 1& de ésta hoja, al no haberse tenido en cuenta el cese de Don Francisco Javier SebastiáAguilar como consejero, que fue adoptado también en la junta universal de socioscelebrada el 20 de diciembre de 2.007. Datosregistrales. T 9024, L 6309, F 217, S 8, H V 133594, I/A 3 ( 6.10.09).
Ceses/Dimisiones. Secretario: ESPINOSA BOLAÑOS FELIPE. Nombramientos. Secretario: TORRES AVILA PASCUALFRANCISCO. Datos registrales. T 9024, L 6309, F 217, S 8, H V 133594, I/A 4 ( 6.10.09).
17 de Abril de 2009Cambio de domicilio social. C/ COLON 7 3 7 (VALENCIA). Datos registrales. T 9024, L 6309, F 217, S 8, H V 133594, I/A 2 (6.04.09).
02 de Abril de 2009Ceses/Dimisiones. Consejero: BATALLA REIGADA GABRIEL ALBERTO;CASANOVA CLARAMONTE VICENTE. Vicepresid.:CASANOVA CLARAMONTE VICENTE. Cons.Del.Man: ESPINOSA BOLAÑOS FELIPE. Consejero: GINER MARTI MANUEL.Secretario: GINER MARTI MANUEL. Consejero: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Presidente: GARCIA ANTON JOSE RAMON.Cons.Del.Man: GARCIA ANTON JOSE RAMON. Consejero: GOMEZ ADELANTADO SANTIAGO. Cons.Del.Man: GOMEZADELANTADO SANTIAGO. Consejero: GOMEZ SAFONT ARCADIO. Cons.Del.Man: GOMEZ SAFONT ARCADIO. Consejero:MARTINEZ CAPDEVILA FRANCISCO. Vicepresid.: MARTINEZ CAPDEVILA FRANCISCO. Consejero: OLLER SANZ JUANALBERTO;REY SANJURJO ANGEL;FLOR GALLEN JORGE JUAN. Nombramientos. Consejero: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS.Co.De.Ma.So: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS. Cons.Del.Man: ESPINOSA BOLAÑOS FELIPE. Consejero: TORRES AVILA PASCUALFRANCISCO;MENDOZA MARTOS MIGUEL ANGEL;MARTIN RUIZ ROCIO;QUILIS MERIN JULIO JOSE;DE BERNARDO SANCHISADOLFO. Presidente: MUÑOZ PEIRATS JOSE LUIS. Secretario: ESPINOSA BOLAÑOS FELIPE. Datos registrales. T 1299, L 862, F198, S 8, H CS 24731, I/A 6 (24.03.09).