Actos BORME de Tecnifoam Sociedad Limitada
26 de Octubre de 2022Cambio de denominaci贸n social. UNICHEM IBERICA SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1045, L 809, F 67, S 8, H AB13589, I/A 20 (19.10.22).
24 de Octubre de 2022Reelecciones. Auditor: AUDITING B. & G. ASSOCIATES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1045, L 809, F 66, S 8, H AB13589, I/A 19 (17.10.22).
22 de Abril de 2022Nombramientos. Apoderado: JOVE PONS LUIS;FAURA BUSTO ALBERTO. Datos registrales. T 1045, L 809, F 66, S 8, H AB13589, I/A 18 (13.04.22).
17 de Agosto de 2021Nombramientos. Apoderado: HUESCA PAYA DANIEL. Datos registrales. T 1007, L 771, F 66, S 8, H AB 13589, I/A 17 (10.08.21).
28 de Octubre de 2020Nombramientos. Apoderado: HUESCA PAYA DANIEL. Datos registrales. T 1007, L 771, F 66, S 8, H AB 13589, I/A 16 (21.10.20).
07 de Noviembre de 2019Revocaciones. Auditor: CASAMITJANA E IBORRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Nombramientos. Auditor: AUDITING B.& G. ASSOCIATES SOCIEDAD LIMITADA. Datos registrales. T 1007, L 771, F 66, S 8, H AB 13589, I/A 15 (23.10.19).
16 de Mayo de 2019Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: MARLIONA CAPITAL SOCIEDAD LIMITADA. Ceses/Dimisiones. Adm. Unico:MARTINELLI SILVANO. Nombramientos. Adm. Unico: JOVE PONS LUIS. Datos registrales. T 964, L 728, F 172, S 8, H AB13589, I/A 11 ( 8.05.19).
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ANTON VICENTE. Datos registrales. T 1007, L 771, F 65, S 8, H AB 13589, I/A 12 ( 8.05.19).
Nombramientos. Apoderado: FAURA BUSTO ALBERTO. Datos registrales. T 1007, L 771, F 65, S 8, H AB 13589, I/A 13 (8.05.19).
Nombramientos. Apoderado: MARTINELLI SILVANO. Datos registrales. T 1007, L 771, F 65, S 8, H AB 13589, I/A 14 ( 8.05.19).
08 de Febrero de 2019Nombramientos. Auditor: CASAMITJANA E IBORRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 964, L 728, F 172,S 8, H AB 13589, I/A 10 ( 1.02.19).
30 de Diciembre de 2016Nombramientos. Auditor: CASAMITJANA E IBORRA AUDITORES SOCIEDAD LIMITADA P. Datos registrales. T 964, L 728, F 172,S 8, H AB 13589, I/A 9 (22.12.16).
04 de Febrero de 2016Nombramientos. Apoderado: LOPEZ ANTON VICENTE. Datos registrales. T 837, L 601, F 11, S 8, H AB 13589, I/A 8 (28.01.16).
06 de Octubre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: LOPEZ ANTON VICENTE. Nombramientos. Adm. Unico: MARTINELLI SILVANO. Datosregistrales. T 837, L 601, F 11, S 8, H AB 13589, I/A 7 (29.09.15).
04 de Febrero de 2014Ampliaci贸n de capital. Capital: 12.808,00 Euros. Resultante Suscrito: 75.818,00 Euros. Datos registrales. T 837, L 601, F 10, S 8,H AB 13589, I/A 6 (28.01.14).
06 de Noviembre de 2013Ceses/Dimisiones. Adm. Solid.: LOPEZ ANTON VICENTE;MARTINEZ REQUENA MARIA GLORIA. Nombramientos. Adm. Unico:LOPEZ ANTON VICENTE. Datos registrales. T 837, L 601, F 10, S 8, H AB 13589, I/A 4 (29.10.13).
Revocaciones. Apo.Sol.: LOPEZ ANTON VICENTE;MARTINEZ REQUENA MARIA GLORIA. Datos registrales. T 837, L 601, F 10,S 8, H AB 13589, I/A 5 (29.10.13).