Actos BORME de Tecnitrade Internacional Sl
20 de Diciembre de 2023Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ-VILLA MATONS JUAN MARTIN. Datos registrales. T 43980 , F 110, S 8, H M 26334, I/A32 (13.12.23).
28 de Noviembre de 2022Nombramientos. Cons.Del.Sol: RODRIGUEZ-VILLA MATONS ANDRES;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL.Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL. Secretario:RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL. Presidente: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Datos registrales. T 12674 , F20, S 8, H M 26334, I/A 31 (21.11.22).
10 de Agosto de 2018Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ VILLA MATONSALEJANDRO. Vicepresid.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Nombramientos. Consejero: RODRIGUEZ-VILLA MATONSJUAN MARTIN. Datos registrales. T 12674 , F 20, S 8, H M 26334, I/A 30 ( 3.08.18).
17 de Julio de 2018Fe de erratas: SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 28陋 EL CONSEJO DE ADMINISTRACION QUEDANDORECTIFICADO. Datos registrales. T 12674 , F 19, S 8, H M 26334, I/A 28 (27.07.17).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Presidente: RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Vicepresid.:RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Vicesecret.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Nombramientos. Presidente:RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Vicepresid.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Datos registrales. T 12674 , F 19,S 8, H M 26334, I/A 28 (27.07.17).
07 de Noviembre de 2017Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ-VILLA MATONS MARIA EMILIA. Datos registrales. T 12674 , F 19, S 8, H M 26334, I/A29 (27.10.17).
07 de Agosto de 2017Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLAMATONS JOSE MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Secretario: RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL.Presidente: RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLAMATONS JOSE MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Vicepresid.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Vicesecret.:RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Datos registrales. T 12674 , F 19, S 8, H M 26334, I/A 28 (27.07.17).
04 de Enero de 2013Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS AUGUSTO;ZUBELDIA JOVE FRANCISCO JAVIER. Datosregistrales. T 12674 , F 18, S 8, H M 26334, I/A 27 (27.12.12).
04 de Octubre de 2011Ampliaci贸n de capital. Capital: 237.106,52 Euros. Resultante Suscrito: 354.902,52 Euros. Datos registrales. T 12674 , F 16, S 8, HM 26334, I/A 26 (22.09.11).
30 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Vicesecret.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ VILLA MATONSALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL. Nombramientos. Cons.Del.Man: RODRIGUEZ VILLA MATONSALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES. Vicepresid.: RODRIGUEZVILLA MATONS ANDRES. Vicesecret.: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO. Reelecciones. Consejero: RODRIGUEZ VILLAMATONS AUGUSTO;RODRIGUEZ VILLA MATONS ANDRES;ZUBELDIA JOVE FRANCISCO JAVIER;RODRIGUEZ VILLA MATONSALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL;RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Secretario: RODRIGUEZ VILLAMATONS JOSE MANUEL. Presidente: RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Datos registrales. T 12674 , F 16, S 8, H M 26334, I/A25 (20.09.11).
24 de Junio de 2011Nombramientos. Apoderado: RODRIGUEZ VILLA MATONS ALEJANDRO;RODRIGUEZ VILLA MATONS JOSE MANUEL. Datosregistrales. T 12674 , F 15, S 8, H M 26334, I/A 24 (13.06.11).
22 de Junio de 2011Ceses/Dimisiones. Vicepresid.: RODRIGUEZ VILLA MATONS AUGUSTO. Co.De.Ma.So: RODRIGUEZ VILLA MATONS AUGUSTO.Datos registrales. T 12674 , F 15, S 8, H M 26334, I/A 23 (13.06.11).
21 de Junio de 2011Nombramientos. Presidente: RODRIGUEZ VILLA MATONS JUAN. Datos registrales. T 12674 , F 15, S 8, H M 26334, I/A 21 (9.06.11).
Ceses/Dimisiones. Consejero: RODRIGUEZ VILLA MATONS MARIA EUGENIA. Datos registrales. T 12674 , F 15, S 8, H M 26334,I/A 22 ( 9.06.11).
15 de Marzo de 2011Ceses/Dimisiones. Consejero: MATONS ROSSI EUGENIA. Presidente: MATONS ROSSI EUGENIA. Datos registrales. T 12674 , F15, S 8, H M 26334, I/A 20 ( 3.03.11).