Buscador CIF Logo

Actos BORME Tecnocontrol Servicios Sa

驴Quieres acceder a la API de EMPRESAS CIF? Obten la informaci贸n de todas las empresas en tiempo real desde tu plataforma.
Ahora con un 25% de DESCUENTO el primer MES. Quiero la API de EMPRESAS

Logo cabecera Tecnocontrol Servicios Sa

Actos BORME Tecnocontrol Servicios Sa - A28815322

Tenemos registrados 68 Actos BORME del Registro Mercantil de Madrid para Tecnocontrol Servicios Sa con CIF A28815322

馃敊 Perfil de Tecnocontrol Servicios Sa
馃洅 Comprar listado completo de Empresas de Madrid

Actos BORME de Tecnocontrol Servicios Sa

14 de Diciembre de 2023
Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32924 , F 182, S 8, H M 55925,I/A 142 ( 5.12.23).

28 de Septiembre de 2023
Nombramientos. Apo.Sol.: GAMAZO VAZQUEZ ALBERTO. Apo.Manc.: GAMAZO VAZQUEZ ALBERTO. Datos registrales. T32924 , F 182, S 8, H M 55925, I/A 141 (21.09.23).

05 de Diciembre de 2022
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 140 (28.11.22).

16 de Diciembre de 2021
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 139 ( 9.12.21).

06 de Septiembre de 2021
Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 138 (30.08.21).

06 de Julio de 2021
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ALLER ROMAN PEDROANTONIO. Datos registrales. T 32924 , F 179, S 8, H M 55925, I/A 136 (29.06.21).

Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32924 , F 179, S 8, H M 55925, I/A 137(29.06.21).

17 de Diciembre de 2020
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NORES LARI脩O ENRIQUE. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 135(10.12.20).

10 de Noviembre de 2020
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 134 (30.10.20).

03 de Enero de 2020
Revocaciones. Apo.Man.Soli: PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 133 (26.12.19).

28 de Octubre de 2019
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 132 (21.10.19).

14 de Marzo de 2019
Nombramientos. Apoderado: REY LAREDO JACINTO. Datos registrales. T 32924 , F 176, S 8, H M 55925, I/A 131 ( 6.03.19).

23 de Noviembre de 2018
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 176, S 8, H M 55925, I/A 130 (15.11.18).

19 de Noviembre de 2018
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ASOREY VILA JAVIER. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 129 (12.11.18).

09 de Octubre de 2017
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 128 (29.09.17).

03 de Noviembre de 2016
Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 127(26.10.16).

17 de Octubre de 2016
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 126 ( 7.10.16).

04 de Agosto de 2016
Reelecciones. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 125(27.07.16).

30 de Mayo de 2016
Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 124(19.05.16).

23 de Diciembre de 2015
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 123 (15.12.15).

21 de Diciembre de 2015
Modificaciones estatutarias. 11bis. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 122(11.12.15).

29 de Julio de 2015
Modificaciones estatutarias. 30. Retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n.. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A121 (21.07.15).

31 de Marzo de 2015
Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ASPE GREGORIO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A

01 de Diciembre de 2014
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A 119 (21.11.14).

09 de Junio de 2014
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Apo.Man.Soli: ALVAREZ DURRIF LUIS MANUEL. Apoderado:GOMEZ TRABADO JOSE ANTONIO;VALMORISCO CORTES JULIO CESAR;MOLINA VERA ANGEL LUIS;SAN JUAN MARTINSONIA;CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: MOREDO ARAUJO JAVIER;PICAS FERRAN RAMON. Apoderado: LOPEZJIMENEZ JORGE;TORRES DE LA CRUZ JORGE;CAMPO CUESTA JULIO;NOBRE GADOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 ,F 225, S 8, H M 55925, I/A 118 (30.05.14).

20 de Noviembre de 2013
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A 117 (12.11.13).

22 de Mayo de 2013
Nombramientos. Apoderado: GOMEZ TRABADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 224, S 8, H M 55925, I/A 116(13.05.13).

09 de Mayo de 2013
Ampliacion del objeto social. A) La realizaci贸n de estudios, proyectos, jecuci贸n y mantenimiento de todotipo de instalaciones, yasean aut贸nomas o en edificaciones y en obras civiles, cualquiera que sea su uso, p煤blicas o privadas, civiles o militares. Datosregistrales. T 22417 , F 223, S 8, H M 55925, I/A 114 (29.04.13).

Revocaciones. Apoderado: PAZ CASTRO LUIS. Apo.Man.Soli: PAZ CASTRO LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 224, S 8, H M55925, I/A 115 (29.04.13).

26 de Marzo de 2013
Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2.005,POR EL NOTARIO DE TRES CANTOS,D. JOSE ANGEL GOMEZ-MORAN ETCHART, CON EL NUMERO 1.299, QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 43&, EN EL SENTIDO DEHACER CONSTAR QUE EL SEGUNDO APELLIDO DEL APODERADO QUE SE MENCIONO EN PRIMER LUGAR ES "TRABADO" .Datos registrales. T 22417 , F 223, S 8, H M 55925, I/A 113 (15.03.13).

13 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apoderado: SAN JUAN MARTIN SONIA. Datos registrales. T 22417 , F 220, S 8, H M 55925, I/A 110 ( 5.02.13).

Nombramientos. Apoderado: TORRES DE LA CRUZ JORGE. Datos registrales. T 22417 , F 221, S 8, H M 55925, I/A 111 (5.02.13).

Nombramientos. Apoderado: MOREDO ARAUJO JAVIER. Datos registrales. T 22417 , F 222, S 8, H M 55925, I/A 112 ( 5.02.13).

12 de Febrero de 2013
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LIMONCHI PEREZ MANUEL JESUS. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 103 (4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAZ CASTRO LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 214, S 8, H M 55925, I/A 104 ( 4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOBRE GODOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 , F 215, S 8, H M 55925, I/A 105 ( 4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 22417 , F 216, S 8, H M 55925, I/A 106 ( 4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALMORISCO CORTES JULIO CESAR. Datos registrales. T 22417 , F 217, S 8, H M 55925, I/A107 ( 4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 22417 , F 218, S 8, H M 55925, I/A 108 (4.02.13).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 22417 , F 219, S 8, H M 55925, I/A 109 ( 4.02.13).

31 de Octubre de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 102 (19.10.12).

19 de Octubre de 2012
Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 101 (8.10.12).

31 de Julio de 2012
Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SANJOSE CONCESIONES Y SERVICIOS SA. Datos registrales. T22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 99 (18.07.12).

Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ DURRIF LUIS MANUEL;MIR OREA LORENZO. Apo.Man.Soli: SUMOY BERTRAN ESTHER.Apoderado: ANDRES SANCHEZ FRANCESC;GUTIERREZ COLL ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A100 (18.07.12).

10 de Enero de 2012
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 98 (28.12.11).

04 de Noviembre de 2011
Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALLER ROMAN PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZJOSE LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 97 (24.10.11).

15 de Abril de 2011
Cambio de domicilio social. RONDA DE PONIENTE 11 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A96 ( 5.04.11).

04 de Enero de 2011
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 95 (23.12.10).

14 de Octubre de 2010
Nombramientos. Apoderado: NOBRE GADOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A 94 ( 1.10.10).

06 de Septiembre de 2010
Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLALON PRIEGO ENRIQUE ALFONSO. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A 93(26.08.10).

02 de Junio de 2010
Nombramientos. Apoderado: ARMESTO HERBELLA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22417 , F 208, S 8, H M 55925, I/A 90(24.05.10).

Nombramientos. Apoderado: LOPEZ JIMENEZ JORGE;ANDRES SANCHEZ FRANCESC;TORRES DE LA CRUZ JORGE;CAMPOCUESTA JULIO;GUTIERREZ COLL ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 209, S 8, H M 55925, I/A 91 (24.05.10).

Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;SARRAIS GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLINLUIS;CARPINTERO PEREZ FRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A

26 de Marzo de 2010
Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 27.090,00 Euros. Datos registrales. T 22417 , F 207, S 8, H M 55925, I/A 89(15.03.10).

01 de Marzo de 2010
Nombramientos. Apoderado: ENTERO VILLENA DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 149, S 8, H M 55925, I/A 86 (18.02.10).

Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLALON PRIEGO ENRIQUE ALFONSO;SUMOY BERTRAN ESTHER;MOREDO ARAUJOJAVIER;PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 22417 , F 149, S 8, H M 55925, I/A 87 (18.02.10).

Nombramientos. Apoderado: AMADOR BARCIELA ESTELA. Datos registrales. T 22417 , F 207, S 8, H M 55925, I/A 88 (18.02.10).

10 de Noviembre de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 84 (28.10.09).

28 de Octubre de 2009
Revocaciones. Apoderado: ALCARAZ SANCHEZ JORDI;GONZALEZ PARRILA DOLORES;GONZALEZ SALAS DAVID. Datosregistrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 83 (16.10.09).

14 de Octubre de 2009
Otros conceptos: MODIFICACION PARCIAL DEL PROYECTO DE ESCISION. Datos registrales. T 3292 , F 180, S 8, H M 55925,I/A 8/M M ( 1.10.09).

20 de Julio de 2009
Revocaciones. Apoderado: SARRAIX GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 82 ( 8.07.09).

21 de Mayo de 2009
Nombramientos. Apoderado: SARRAIS GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 146, S 8, H M 55925, I/A 81 ( 8.05.09).

13 de Marzo de 2009
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Nombramientos. Apoderado:HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 80 (4.03.09).

30 de Enero de 2009
Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 79 (20.01.09).

22 de Enero de 2009
Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 22417 , F141, S 8, H M 55925, I/A 76 (12.01.09).

Nombramientos. Apoderado: SARRAIX GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 143, S 8, H M 55925, I/A 77 (12.01.09).

Revocaciones. Apoderado: ZAFRA FERNANDEZ DE TEJADA MANUEL. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 78(12.01.09).

20 de Enero de 2009
Revocaciones. Apoderado: LEMA DEVESA JUAN IGNACIO;CORTINES ARELLANO JOSE;SARASOLA DEL CERRO SANTIAGO.Datos registrales. T 22417 , F 140, S 8, H M 55925, I/A 75 ( 8.01.09).

Utilizamos cookies de terceros con finalidades anal铆ticas, de personalizaci贸n, y de publicidad comportamental. Puede configurar ahora el uso de esta tecnolog铆a. Si acepta o contin煤a navegando, consideramos que est谩 de acuerdo con su uso. Mas informaci贸n