Actos BORME de Tecnocontrol Servicios Sa
14 de Diciembre de 2023Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 32924 , F 182, S 8, H M 55925,I/A 142 ( 5.12.23).
28 de Septiembre de 2023Nombramientos. Apo.Sol.: GAMAZO VAZQUEZ ALBERTO. Apo.Manc.: GAMAZO VAZQUEZ ALBERTO. Datos registrales. T32924 , F 182, S 8, H M 55925, I/A 141 (21.09.23).
05 de Diciembre de 2022Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 140 (28.11.22).
16 de Diciembre de 2021Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 139 ( 9.12.21).
06 de Septiembre de 2021Revocaciones. Apo.Man.Soli: LOPEZ JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 32924 , F 181, S 8, H M 55925, I/A 138 (30.08.21).
06 de Julio de 2021Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Nombramientos. Adm. Unico: ALLER ROMAN PEDROANTONIO. Datos registrales. T 32924 , F 179, S 8, H M 55925, I/A 136 (29.06.21).
Nombramientos. Apoderado: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32924 , F 179, S 8, H M 55925, I/A 137(29.06.21).
17 de Diciembre de 2020Nombramientos. Apo.Man.Soli: NORES LARI脩O ENRIQUE. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 135(10.12.20).
10 de Noviembre de 2020Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 134 (30.10.20).
03 de Enero de 2020Revocaciones. Apo.Man.Soli: PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 133 (26.12.19).
28 de Octubre de 2019Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 178, S 8, H M 55925, I/A 132 (21.10.19).
14 de Marzo de 2019Nombramientos. Apoderado: REY LAREDO JACINTO. Datos registrales. T 32924 , F 176, S 8, H M 55925, I/A 131 ( 6.03.19).
23 de Noviembre de 2018Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 176, S 8, H M 55925, I/A 130 (15.11.18).
19 de Noviembre de 2018Nombramientos. Apo.Man.Soli: ASOREY VILA JAVIER. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 129 (12.11.18).
09 de Octubre de 2017Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 128 (29.09.17).
03 de Noviembre de 2016Revocaciones. Apoderado: MERINO LANZA MANUEL JOSE. Datos registrales. T 32924 , F 175, S 8, H M 55925, I/A 127(26.10.16).
17 de Octubre de 2016Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 126 ( 7.10.16).
04 de Agosto de 2016Reelecciones. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 125(27.07.16).
30 de Mayo de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 124(19.05.16).
23 de Diciembre de 2015Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 123 (15.12.15).
21 de Diciembre de 2015Modificaciones estatutarias. 11bis. Acciones/Participaciones.-. Datos registrales. T 32924 , F 174, S 8, H M 55925, I/A 122(11.12.15).
29 de Julio de 2015Modificaciones estatutarias. 30. Retribuci贸n del 贸rgano de administraci贸n.. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A121 (21.07.15).
31 de Marzo de 2015Revocaciones. Apoderado: LOPEZ ASPE GREGORIO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A
01 de Diciembre de 2014Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A 119 (21.11.14).
09 de Junio de 2014Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Apo.Man.Soli: ALVAREZ DURRIF LUIS MANUEL. Apoderado:GOMEZ TRABADO JOSE ANTONIO;VALMORISCO CORTES JULIO CESAR;MOLINA VERA ANGEL LUIS;SAN JUAN MARTINSONIA;CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Apo.Man.Soli: MOREDO ARAUJO JAVIER;PICAS FERRAN RAMON. Apoderado: LOPEZJIMENEZ JORGE;TORRES DE LA CRUZ JORGE;CAMPO CUESTA JULIO;NOBRE GADOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 ,F 225, S 8, H M 55925, I/A 118 (30.05.14).
20 de Noviembre de 2013Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 225, S 8, H M 55925, I/A 117 (12.11.13).
22 de Mayo de 2013Nombramientos. Apoderado: GOMEZ TRABADO JOSE ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 224, S 8, H M 55925, I/A 116(13.05.13).
09 de Mayo de 2013Ampliacion del objeto social. A) La realizaci贸n de estudios, proyectos, jecuci贸n y mantenimiento de todotipo de instalaciones, yasean aut贸nomas o en edificaciones y en obras civiles, cualquiera que sea su uso, p煤blicas o privadas, civiles o militares. Datosregistrales. T 22417 , F 223, S 8, H M 55925, I/A 114 (29.04.13).
Revocaciones. Apoderado: PAZ CASTRO LUIS. Apo.Man.Soli: PAZ CASTRO LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 224, S 8, H M55925, I/A 115 (29.04.13).
26 de Marzo de 2013Otros conceptos: SE SUBSANA LA ESCRITURA AUTORIZADA EL 21 DE ABRIL DE 2.005,POR EL NOTARIO DE TRES CANTOS,D. JOSE ANGEL GOMEZ-MORAN ETCHART, CON EL NUMERO 1.299, QUE ORIGINO LA INSCRIPCION 43&, EN EL SENTIDO DEHACER CONSTAR QUE EL SEGUNDO APELLIDO DEL APODERADO QUE SE MENCIONO EN PRIMER LUGAR ES "TRABADO" .Datos registrales. T 22417 , F 223, S 8, H M 55925, I/A 113 (15.03.13).
13 de Febrero de 2013Nombramientos. Apoderado: SAN JUAN MARTIN SONIA. Datos registrales. T 22417 , F 220, S 8, H M 55925, I/A 110 ( 5.02.13).
Nombramientos. Apoderado: TORRES DE LA CRUZ JORGE. Datos registrales. T 22417 , F 221, S 8, H M 55925, I/A 111 (5.02.13).
Nombramientos. Apoderado: MOREDO ARAUJO JAVIER. Datos registrales. T 22417 , F 222, S 8, H M 55925, I/A 112 ( 5.02.13).
12 de Febrero de 2013Nombramientos. Apo.Man.Soli: LIMONCHI PEREZ MANUEL JESUS. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 103 (4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PAZ CASTRO LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 214, S 8, H M 55925, I/A 104 ( 4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: NOBRE GODOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 , F 215, S 8, H M 55925, I/A 105 ( 4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: LOPEZ JIMENEZ JORGE. Datos registrales. T 22417 , F 216, S 8, H M 55925, I/A 106 ( 4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VALMORISCO CORTES JULIO CESAR. Datos registrales. T 22417 , F 217, S 8, H M 55925, I/A107 ( 4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CAJIDE RIVEIRO JOSE MANUEL. Datos registrales. T 22417 , F 218, S 8, H M 55925, I/A 108 (4.02.13).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 22417 , F 219, S 8, H M 55925, I/A 109 ( 4.02.13).
31 de Octubre de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 102 (19.10.12).
19 de Octubre de 2012Revocaciones. Apoderado: MARTINEZ CARBALLAL SANTIAGO. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A 101 (8.10.12).
31 de Julio de 2012Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: SANJOSE CONCESIONES Y SERVICIOS SA. Datos registrales. T22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 99 (18.07.12).
Revocaciones. Apoderado: ALVAREZ DURRIF LUIS MANUEL;MIR OREA LORENZO. Apo.Man.Soli: SUMOY BERTRAN ESTHER.Apoderado: ANDRES SANCHEZ FRANCESC;GUTIERREZ COLL ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 213, S 8, H M 55925, I/A100 (18.07.12).
10 de Enero de 2012Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 98 (28.12.11).
04 de Noviembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: ALLER ROMAN PEDRO ANTONIO. Nombramientos. Adm. Unico: GONZALEZ RODRIGUEZJOSE LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 97 (24.10.11).
15 de Abril de 2011Cambio de domicilio social. RONDA DE PONIENTE 11 (TRES CANTOS). Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A96 ( 5.04.11).
04 de Enero de 2011Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 212, S 8, H M 55925, I/A 95 (23.12.10).
14 de Octubre de 2010Nombramientos. Apoderado: NOBRE GADOY ADOLFO. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A 94 ( 1.10.10).
06 de Septiembre de 2010Revocaciones. Apo.Man.Soli: VILLALON PRIEGO ENRIQUE ALFONSO. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A 93(26.08.10).
02 de Junio de 2010Nombramientos. Apoderado: ARMESTO HERBELLA MIGUEL ANGEL. Datos registrales. T 22417 , F 208, S 8, H M 55925, I/A 90(24.05.10).
Nombramientos. Apoderado: LOPEZ JIMENEZ JORGE;ANDRES SANCHEZ FRANCESC;TORRES DE LA CRUZ JORGE;CAMPOCUESTA JULIO;GUTIERREZ COLL ANTONIO. Datos registrales. T 22417 , F 209, S 8, H M 55925, I/A 91 (24.05.10).
Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;SARRAIS GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLINLUIS;CARPINTERO PEREZ FRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 210, S 8, H M 55925, I/A
26 de Marzo de 2010Desembolso de dividendos pasivos. Desembolsado: 27.090,00 Euros. Datos registrales. T 22417 , F 207, S 8, H M 55925, I/A 89(15.03.10).
01 de Marzo de 2010Nombramientos. Apoderado: ENTERO VILLENA DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 149, S 8, H M 55925, I/A 86 (18.02.10).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: VILLALON PRIEGO ENRIQUE ALFONSO;SUMOY BERTRAN ESTHER;MOREDO ARAUJOJAVIER;PICAS FERRAN RAMON. Datos registrales. T 22417 , F 149, S 8, H M 55925, I/A 87 (18.02.10).
Nombramientos. Apoderado: AMADOR BARCIELA ESTELA. Datos registrales. T 22417 , F 207, S 8, H M 55925, I/A 88 (18.02.10).
10 de Noviembre de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 84 (28.10.09).
28 de Octubre de 2009Revocaciones. Apoderado: ALCARAZ SANCHEZ JORDI;GONZALEZ PARRILA DOLORES;GONZALEZ SALAS DAVID. Datosregistrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 83 (16.10.09).
14 de Octubre de 2009Otros conceptos: MODIFICACION PARCIAL DEL PROYECTO DE ESCISION. Datos registrales. T 3292 , F 180, S 8, H M 55925,I/A 8/M M ( 1.10.09).
20 de Julio de 2009Revocaciones. Apoderado: SARRAIX GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 147, S 8, H M 55925, I/A 82 ( 8.07.09).
21 de Mayo de 2009Nombramientos. Apoderado: SARRAIS GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 146, S 8, H M 55925, I/A 81 ( 8.05.09).
13 de Marzo de 2009Revocaciones. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Nombramientos. Apoderado:HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 80 (4.03.09).
30 de Enero de 2009Reelecciones. Auditor: DELOITTE SL. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 79 (20.01.09).
22 de Enero de 2009Nombramientos. Apoderado: HERNANDEZ GONZALEZ JUAN FELIX;MOLINA VERA ANGEL LUIS. Datos registrales. T 22417 , F141, S 8, H M 55925, I/A 76 (12.01.09).
Nombramientos. Apoderado: SARRAIX GRAU JOSE ANTONIO;MOROS COSCOLIN LUIS;CARPINTERO PEREZFRANCISCO;TORREGO FERNANDEZ DAVID. Datos registrales. T 22417 , F 143, S 8, H M 55925, I/A 77 (12.01.09).
Revocaciones. Apoderado: ZAFRA FERNANDEZ DE TEJADA MANUEL. Datos registrales. T 22417 , F 144, S 8, H M 55925, I/A 78(12.01.09).
20 de Enero de 2009Revocaciones. Apoderado: LEMA DEVESA JUAN IGNACIO;CORTINES ARELLANO JOSE;SARASOLA DEL CERRO SANTIAGO.Datos registrales. T 22417 , F 140, S 8, H M 55925, I/A 75 ( 8.01.09).