Actos BORME de Telecon Sistemas Sa
25 de Mayo de 2020Revocaciones. ADM.CONCURS.: ZARCO PUENTE CARLOS. Otros conceptos: JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 501/2017, AUTO FIRME DE FECHA 20/02/2020, CONCLUSION DELCONCURSO. Extinci贸n. Datos registrales. T 42455 , F 37, S 8, H B 230, I/A 22 (18.05.20).
15 de Junio de 2018Revocaciones. ADM.UNICO: COLOMERA AGUILA DARIO MIGUEL. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 2 DEBARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 501/2017, AUTOS FIRMES DE FECHAS 12/01/2018: APERTURA DELA FASE DE LIQUIDACION Y 19/03/2018: APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION. Disoluci贸n. Judicial. Datos registrales. T42455 , F 36, S 8, H B 230, I/A 21 ( 8.06.18).
27 de Octubre de 2017Nombramientos. ADM.CONCURS.: ZARCO PUENTE CARLOS. Otros conceptos: JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA,PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 501/2017, AUTO FIRME DE FECHA 11/07/2017, DECLARACIONDE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD. Datos registrales. T 42455 , F 35, S 8, H B 230, I/A 20 (20.10.17).
04 de Junio de 2014Revocaciones. ADM.UNICO: COLOMERA GIMENEZ ANTONIO. Nombramientos. ADM.UNICO: COLOMERA AGUILA DARIOMIGUEL. APODERAD.SOL: COLOMERA GIMENEZ ANTONIO. Modificaciones estatutarias. ART.11.- SISTEMA RETRIBUTIVODEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL. Datos registrales. T 42455 , F 34, S 8, H B 230, I/A 19 (28.05.14).
12 de Febrero de 2014Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TELECON PRINTING SOLUTIONS SL. Datos registrales. T 42455 , F 32, S 8, H B230, I/A 18 ( 5.02.14).
27 de Enero de 2014Reducci贸n de capital. Importe reducci贸n: 1,21 Euros. Resultante Suscrito: 60.100,00 Euros. Ampliaci贸n de capital. Suscrito:120.048,00 Euros. Desembolsado: 120.048,00 Euros. Resultante Suscrito: 180.148,00 Euros. Resultante Desembolsado: 180.148,00Euros. Modificaciones estatutarias. Art. 6.-CREACION DE SERIES DE ACCIONES.ART.10.-JUNTA GENERAL. Otros conceptos:PERDIDA DE LA CONDICION DE UNIPERSONALIDAD. Datos registrales. T 42455 , F 31, S 8, H B 230, I/A 17 (17.01.14).
11 de Marzo de 2011Nombramientos. APODERADO: COLOMERA AGUILA DARIO MIGUEL. Datos registrales. T 20017 , F 179, S 8, H B 230, I/A 16 (1.03.11).
15 de Febrero de 2011Revocaciones. APODERADO: COLOMERA GIMENEZ ANTONIO;MONLLAU PAYTUVI ALBERTO;MIRO TORRES JAVIER MARIA.Datos registrales. T 20017 , F 179, S 8, H B 230, I/A 15 ( 3.02.11).
01 de Octubre de 2010Nombramientos. ADM.UNICO: COLOMERA GIMENEZ ANTONIO. Datos registrales. T 20017 , F 179, S 8, H B 230, I/A 14