Actos BORME de Telefonica Gestion Integral De Edificios Y Servicios Sl
18 de Octubre de 2023Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TEMPOTEL EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA. Datos registrales. T 29897, F 81, S 8, H M 538046, I/A 34 (10.10.23).
25 de Septiembre de 2023Reelecciones. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29897 , F 81, S 8, H M 538046, I/A33 (18.09.23).
29 de Diciembre de 2022Nombramientos. Apo.Sol.: VEDIA SANZ DAVID. Datos registrales. T 29897 , F 80, S 8, H M 538046, I/A 32 (21.12.22).
30 de Diciembre de 2021Reelecciones. Adm. Unico: CARCAMO GABARI FELIX VALENTIN. Datos registrales. T 29897 , F 80, S 8, H M 538046, I/A 31(23.12.21).
19 de Noviembre de 2020Nombramientos. Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL. Datos registrales. T 29897 , F 80, S 8, H M 538046,I/A 30 (12.11.20).
26 de Agosto de 2020Revocaciones. Apo.Sol.: YUSTE RODRIGUEZ ELENA. Datos registrales. T 29897 , F 80, S 8, H M 538046, I/A 29 (19.08.20).
25 de Agosto de 2020Fusi贸n por absorci贸n. Sociedades absorbidas: TAETEL SL. Datos registrales. T 29897 , F 77, S 8, H M 538046, I/A 28 (18.08.20).
19 de Agosto de 2020Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29897 , F 77, S 8, H M 538046, I/A 27 (12.08.20).
07 de Agosto de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29897 , F 77, S 8, H M 538046, I/A 26 (30.07.18).
30 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29897 , F 77, S 8, H M 538046, I/A 25 (23.05.18).
28 de Mayo de 2018Nombramientos. Apoderado: FEITO ALONSO MARIA DE LAS NIEVES;DUCHA SUTIL EVANGELINA;MU脩OZ FORAMARTA;PEREZ CANTON JESUS MANUEL;CALVO CASTRO CARLOS. Datos registrales. T 29897 , F 76, S 8, H M 538046, I/A 24(21.05.18).
21 de Mayo de 2018Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29897 , F 76, S 8, H M 538046, I/A 23 (11.05.18).
25 de Agosto de 2017Revocaciones. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALONSO MARIA ISABEL. Apo.Manc.: MARTINEZ PARRILLA CONCEPCION. Apo.Sol.:MARTINEZ CEJAS VICTOR JOSE. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MIGUEL IVAN. Datos registrales. T 29897 , F 76, S 8, H M 538046,I/A 22 (17.08.17).
29 de Diciembre de 2016Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: SANCHEZ LOPEZ JESUS. Nombramientos. Adm. Unico: CARCAMO GABARI FELIX VALENTIN.Datos registrales. T 29897 , F 76, S 8, H M 538046, I/A 21 (20.12.16).
27 de Septiembre de 2016Nombramientos. Apoderado: RUIZ DE LA CUESTA RIOS MARIA DEL PUY. Datos registrales. T 29897 , F 75, S 8, H M 538046,I/A 20 (19.09.16).
14 de Julio de 2016Reelecciones. Auditor: BDO AUDITORES SLP. Datos registrales. T 29897 , F 75, S 8, H M 538046, I/A 19 ( 6.07.16).
21 de Abril de 2016Revocaciones. Apo.Man.Soli: VICENTE GOMEZ ESTHER;CABRERO GONZALEZ MANUEL JULIAN;PERDICES CAJAMARTA;ABAD GONZALEZ JOSE ALBERTO. Nombramientos. Apo.Sol.: RUIZ DE LA CUESTA RIOS MARIA DEL PUY. Datosregistrales. T 29897 , F 75, S 8, H M 538046, I/A 18 (14.04.16).
13 de Abril de 2016Sociedad unipersonal. Cambio de identidad del socio 煤nico: TELEFONICA SERVICIOS GLOBALES SL. Datos registrales. T29897 , F 74, S 8, H M 538046, I/A 17 ( 5.04.16).
12 de Noviembre de 2013Revocaciones. Apo.Man.Soli: DE LA MATA SANCHEZ GERARDO;GARCIA ARRANZ YOLANDA. Apo.Sol.: LOPEZ DE GRACIAJOSE JAVIER. Nombramientos. Apo.Man.Soli: GONZALEZ MIGUEL IVAN. Datos registrales. T 29897 , F 74, S 8, H M 538046, I/A16 ( 5.11.13).
27 de Noviembre de 2012Nombramientos. Auditor: BDO AUDITORES SL. Datos registrales. T 29897 , F 74, S 8, H M 538046, I/A 15 (14.11.12).
27 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apo.Sol.: LOPEZ DE GRACIA JOSE JAVIER. Datos registrales. T 29897 , F 73, S 8, H M 538046, I/A 14(18.09.12).
19 de Septiembre de 2012Nombramientos. Apo.Manc.: MARTINEZ PARRILLA CONCEPCION. Datos registrales. T 29897 , F 72, S 8, H M 538046, I/A 12 (6.09.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: MARTINEZ CEJAS VICTOR JOSE. Datos registrales. T 29897 , F 73, S 8, H M 538046, I/A 13 (6.09.12).
22 de Agosto de 2012Nombramientos. Apo.Man.Soli: VICENTE GOMEZ ESTHER. Datos registrales. T 29897 , F 67, S 8, H M 538046, I/A 2 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: RUIZ DE LA CUESTA RIOS MARIA DEL PUY. Datos registrales. T 29897 , F 68, S 8, H M 538046,I/A 3 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: YUSTE RODRIGUEZ ELENA. Datos registrales. T 29897 , F 70, S 8, H M 538046, I/A 4 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Sol.: ALEJANDRO ANG JOSE. Datos registrales. T 29897 , F 70, S 8, H M 538046, I/A 5 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: DE LA MATA SANCHEZ GERARDO. Datos registrales. T 29897 , F 70, S 8, H M 538046, I/A 6 (7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: CABRERO GONZALEZ MANUEL JULIAN. Datos registrales. T 29897 , F 71, S 8, H M 538046, I/A7 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: PERDICES CAJA MARTA. Datos registrales. T 29897 , F 71, S 8, H M 538046, I/A 8 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: GARCIA ARRANZ YOLANDA. Datos registrales. T 29897 , F 71, S 8, H M 538046, I/A 9 ( 7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: ABAD GONZALEZ JOSE ALBERTO. Datos registrales. T 29897 , F 72, S 8, H M 538046, I/A 10 (7.08.12).
Nombramientos. Apo.Man.Soli: MARTINEZ ALONSO MARIA ISABEL. Datos registrales. T 29897 , F 72, S 8, H M 538046, I/A 11 (7.08.12).
10 de Julio de 2012Constituci贸n. Comienzo de operaciones: 16.05.12. Objeto social: La prestaci贸n de servicios de gesti贸n y administraci贸n en materiade gesti贸n inmobiliaria, procesos de contrataci贸n, seguridad, log铆stica, distribuci贸n, tecnolog铆a, sistemas de informaci贸n y serviciosgenerales. La prestaci贸n de servicios integrales de almacenaje, clasificaci贸n, registro, manipulaci. Domicilio: C/ GRAN VIA 28(MADRID). Capital: 3.006,00 Euros. Declaraci贸n de unipersonalidad. Socio 煤nico: TELEFONICA GESTION DE SERVICIOSCOMPARTIDOS ESPA脩A. Nombramientos. Adm. Unico: SANCHEZ LOPEZ JESUS. Ampliaci贸n de capital. Capital: 271.097,00Euros. Resultante Suscrito: 274.103,00 Euros. Datos registrales. T 29897 , F 61, S 8, H M 538046, I/A 1 (28.06.12).