Actos BORME de Television Autonomica De Castilla-la Mancha Sa
16 de Febrero de 2022Nombramientos. Auditor: BLAZQUEZ ASOCIADOS AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1533 , F 70, S 8, H TO 17087, I/A 26 (9.02.22).
03 de Noviembre de 2021Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY AUDITORES SLP. Datos registrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 25 (26.10.21).
15 de Octubre de 2020Reelecciones. Adm. Unico: AMORES GARCIA CARMEN. Datos registrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 24 ( 5.10.20).
18 de Enero de 2018Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP. Datos registrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 23 (11.01.18).
11 de Agosto de 2016Reelecciones. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP. Datos registrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 22 ( 4.08.16).
21 de Julio de 2016Revocaciones. Apo.Sol.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Sol.: VICENS DEL RIO LUISPABLO. Datos registrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 21 (14.07.16).
10 de Septiembre de 2015Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: VILLA CALLEJA IGNACIO. Nombramientos. Adm. Unico: AMORES GARCIA CARMEN. Datosregistrales. T 1533 , F 69, S 8, H TO 17087, I/A 20 ( 3.09.15).
26 de Junio de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Sol.: DE MESA BUIGUESJERONIMO. Apo.Manc.: DE MESA BUIGUES JERONIMO. Datos registrales. T 1529 , F 225, S 8, H TO 17087, I/A 18 (15.06.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO;DE MESA BUIGUES JERONIMO. Apo.Sol.: DE MESA BUIGUESJERONIMO. Apo.Manc.: VICENS DEL RIO LUIS PABLO. Datos registrales. T 1529 , F 225, S 8, H TO 17087, I/A 19 (15.06.15).
04 de Mayo de 2015Nombramientos. Apo.Sol.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Sol.: VICENS DEL RIO LUISPABLO. Apo.Manc.: VICENS DEL RIO LUIS PABLO. Datos registrales. T 1488 , F 52, S 8, H TO 17087, I/A 16 (23.04.15).
Revocaciones. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO;VILLAVERDE CARNEVALI RAMON. Apo.Sol.: ARANA LOPEZFERNANDO;VILLAVERDE CARNEVALI RAMON. Datos registrales. T 1488 , F 52, S 8, H TO 17087, I/A 17 (23.04.15).
13 de Febrero de 2014Nombramientos. Auditor: BAKER TILLY FMAC SLP. Datos registrales. T 1488 , F 52, S 8, H TO 17087, I/A 15 (23.12.13).
26 de Diciembre de 2013Revocaciones. Apo.Manc.: ALARCON CASTILLO BEATRIZ;GARCIA RUBIO GARCIA RAMON MARIA. Datos registrales. T 1488 ,F 52, S 8, H TO 17087, I/A 14 (16.12.13).
21 de Diciembre de 2011Cambio de domicilio social. C/ RIO GUADALMENA, 6 (TOLEDO). Datos registrales. T 1488 , F 51, S 8, H TO 17087, I/A 12(12.12.11).
Nombramientos. Apo.Sol.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Manc.: ARANA LOPEZ FERNANDO. Apo.Sol.: VILLAVERDECARNEVALI RAMON. Apo.Manc.: VILLAVERDE CARNEVALI RAMON. Datos registrales. T 1488 , F 51, S 8, H TO 17087, I/A 13(12.12.11).
13 de Septiembre de 2011Ceses/Dimisiones. Adm. Unico: GARCIA CANDAU JORDI. Nombramientos. Adm. Unico: VILLA CALLEJA IGNACIO. Datosregistrales. T 1488 , F 51, S 8, H TO 17087, I/A 11 ( 1.09.11).
09 de Agosto de 2011Reelecciones. Adm. Unico: GARCIA CANDAU JORDI. Datos registrales. T 1488 , F 51, S 8, H TO 17087, I/A 10 (28.07.11).
04 de Octubre de 2010Nombramientos. Auditor: ACCOUNT CONTROL SOCIEDAD DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 1488 , F 51, S 8, H TO17087, I/A 9 (20.09.10).
01 de Febrero de 2010Reelecciones. Auditor: ACCOUNT CONTROL SOCIEDAD DE AUDITORIA SL. Datos registrales. T 1088 , F 141, S 8, H TO 17087,I/A 8 (18.01.10).
28 de Diciembre de 2009Ampliacion del objeto social. La edici贸n de libros y de soportes grabados de sonido y video y la distribuci贸n, venta y alquiler de losmismos, (excepto el arrendamiento financiero). Datos registrales. T 1088 , F 141, S 8, H TO 17087, I/A 7 (14.12.09).